GIBBS NEWSAGENTS LIMITED

GIBBS NEWSAGENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGIBBS NEWSAGENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02159775
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOODMAN GIBBS LIMITED21 ott 198721 ott 1987
    SWITCHCLASS LIMITED31 ago 198731 ago 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 feb 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD03

    Indirizzo della sede legale modificato da Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 mar 2018

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom a Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 feb 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 gen 2018

    • Capitale: GBP 5,260,948.00
    5 pagineSH01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 feb 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share prem acc cancelled 22/01/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 05 feb 2018

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share prem acc cancelled 22/01/2018
    RES13

    Nomina di Mr Robert John Welch come amministratore in data 09 gen 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tesco Services Limited come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tracey Clements come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Blair come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Steven Blair come amministratore in data 17 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 17 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    British204754740001
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish107529830027
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    BURROWS, Patrick James
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    Segretario
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    British86778310001
    COWELL, Martin William
    32 Beverston Road
    Perton
    WV6 7UG Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    32 Beverston Road
    Perton
    WV6 7UG Wolverhampton
    West Midlands
    British1614020001
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    Segretario
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    British72917320001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Segretario
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    AGER, Rowley Stuart
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72555850002
    BLAIR, Steven
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167430001
    BODDICE, Stephen
    Churchill Old Farm
    Churchill
    DY10 3LZ Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Churchill Old Farm
    Churchill
    DY10 3LZ Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish1673770001
    BURROWS, Patrick James
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    British86778310001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    CRELLIN, David
    191 Worcester Road
    Hagley
    DY9 0PR Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    191 Worcester Road
    Hagley
    DY9 0PR Stourbridge
    West Midlands
    British31677030002
    GIBBONS, Colin Howard
    33 Abbotsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    33 Abbotsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    British61993880001
    GORDON, Timothy Leigh
    2 Sandown Drive
    Halebarns
    WA15 0BA Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    2 Sandown Drive
    Halebarns
    WA15 0BA Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish2900860001
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    EnglandBritish57637410003
    HOLMES, Colin Peter
    66 Tolmers Road
    EN6 4JY Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    66 Tolmers Road
    EN6 4JY Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish86778500001
    KING, Andrew Paul
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish200246970001
    LLOYD, Jonathan Mark
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish160028560001
    MCCARTHY, James John
    Broadview House
    34 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Broadview House
    34 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British2426350005
    MCQUARRIE, Jonny
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167420001
    MOORE, Dean
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    Amministratore
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    British94541520001
    MURRELLS, Steven Geoffrey
    Willow Farm
    Further Street
    CO10 5LD Assington
    Suffolk
    Amministratore
    Willow Farm
    Further Street
    CO10 5LD Assington
    Suffolk
    British98194710001
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish148079740001
    O'NEILL, William Patrick
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British106806380001
    PENFOLD, Julia
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    Amministratore
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    British67318640001
    REED, Anthony William
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish160544960001
    SMITH, Bryan Robin Geoffrey Gilbert
    Queen Annes
    TN17 1BN Goudhurst
    Kent
    Amministratore
    Queen Annes
    TN17 1BN Goudhurst
    Kent
    British34819420002
    SMITH, Richard John
    101 Dropmore Road
    Burnham
    SL1 8AY Slough
    Amministratore
    101 Dropmore Road
    Burnham
    SL1 8AY Slough
    British38475260001
    TURNER, David
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish109813430001
    TURNER, David Richmond
    Woodhouse Farm
    Wyke
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Salop
    Amministratore
    Woodhouse Farm
    Wyke
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Salop
    EnglandBritish13374870003
    WILLIAMS, Mark Benjamin
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish208244710001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Amministratore
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7600956
    175259630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GIBBS NEWSAGENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00243011
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GIBBS NEWSAGENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A guarantee and debenture
    Creato il 28 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the group companies (as defined in the facilities agreement) to (I) each bank (as defined in the facilities agreement) pursuant to the banks' bilateral facilities and/or (ii) to each beneficiary (as defined) pursuant to the senior finance documents (all as defined)
    Brevi particolari
    F/H unit 1,apex road brownhills,west midlands t/no.WM230532;f/h north west side of pelsall road brownhills,west midlands t/no.WM80733;f/h east side of apex road brownhills,west midlands t/no.WM385696.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 1992
    Consegnato il 12 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or gibbs news limited on anyaccount whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M638C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge supplemental to a gurantee and debenture dated 15/5/89
    Creato il 02 mag 1991
    Consegnato il 21 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee as trustee for the banks (as defined in a banking facility agreement dated 15.5.89) pursuant to the terms of the guarantee and debenture and an overdraught letter of even date therewith
    Brevi particolari
    A) by way of legal mortgage 4 limehurst square duston northants b) by way of assignment the benefit to the COMP0ANY of all rights and claims to which the company is or may hereafterbecome entitled in relation to the property (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • /5/89
    • Barclays Bank PLC No Trastee for the Banks as Defined in the Banking Faclity Agreement Dated 15
    Transazioni
    • 21 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 14 feb 1991
    Consegnato il 27 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £28,063,00 being the total amount payable by the company to the chargee pursuantto the term of the agreement
    Brevi particolari
    All right, title and interest in and for all sums payable under the insurance (see form 395 for full detials).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 27 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Gurantee & composite trust debenture
    Creato il 15 mag 1989
    Consegnato il 22 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or surbridge newsagents limited to the chargee under the terms of terms of the charge and/or the bamling facility agreement and/or the overdraft letter.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bardays Bank PLC as Trustee for the Banks as Defined in the Banking Facility Agreement
    Transazioni
    • 22 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 1989
    Consegnato il 21 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33/33A, browns lane, uckfield, east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1988
    Consegnato il 16 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    67/69 lustrells vale saltdean brighton east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 1988
    Consegnato il 22 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 and 17A greenwood road, crowthorne, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 1988
    Consegnato il 22 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Shop number 3, chestnut house, high street, crowthorne, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 ott 1988
    Consegnato il 20 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 20 burntwood town centre shopping centre, chase terrace, cannock staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 ago 1988
    Consegnato il 19 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises situate and k/a 112 whitehorse lane in the london borough of tower hamlets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 apr 1988
    Consegnato il 27 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises situate and k/as 65 caledonian chscote tamworth staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1988
    Consegnato il 17 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises situate and k/a 188 & 190 ferndale road swindon wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1988
    Consegnato il 03 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a or being 3 dunsham lane aylesbury buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1988
    Consegnato il 03 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as 304 and 306 meadowcroft, aylesbury, buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1988
    Consegnato il 03 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a flat 4 33 and 33A brownd lane, uckfield sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1988
    Consegnato il 15 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property k/as all that lockup shop and maisonette and other buildings k/as 2 and 10 covingham square covingham swindon, wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 1988
    Consegnato il 27 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as or being all that lock store containing about 94 sq. Feet at covingham square swindon in the county of wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 gen 1988
    Consegnato il 22 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leashold premises k/a 493 bromley road dowaham kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1988
    Consegnato il 22 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Vee house, park industrial estate, hogmors st albans herts, AL2 2DR.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1987
    Consegnato il 30 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises k/a 3 curtis place and 63A high street, kidlington, oxon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1987
    Consegnato il 30 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises k/a 59 and 61A high street kidlington oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1987
    Consegnato il 24 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises k/a 16 market wrytle lane carshalton, surrey SN5 1AG.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1987
    Consegnato il 30 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises k/a shop number 223 and garage no. 11 and flat 237 st marks road tipton staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 dic 1987
    Consegnato il 18 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises k/a 2 alderwood precinct northway dudley west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GIBBS NEWSAGENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2018Inizio della liquidazione
    07 mar 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0