PROFILEX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROFILEX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02161775
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROFILEX LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova PROFILEX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROFILEX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per PROFILEX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 set 2010

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Saint-Gobain House Binley Business Park Coventry CV3 2TT in data 08 ott 2010

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Nomina di Mr Philip Edward Moore come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thierry Lambert come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ago 2010

    Stato del capitale al 18 ago 2010

    • Capitale: GBP 83,476
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Thierry Lambert il 24 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Alun Roy Oxenham il 28 apr 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Alun Roy Oxenham il 28 apr 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di PROFILEX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OXENHAM, Alun Roy
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Segretario
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    British72478560002
    MOORE, Philip Edward
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Amministratore
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector60599570002
    OXENHAM, Alun Roy
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Amministratore
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary72478560002
    CAMMACK, Nicholas James
    297a High Road
    Chilwell
    NG9 5DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    297a High Road
    Chilwell
    NG9 5DD Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director114260730001
    CARPENTER, Clare
    8 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    Segretario
    8 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    British3050110002
    COULSON, Clifford Beeby
    Cheltenham
    Green Lane
    LE9 8JP Stapleton
    Leicestershire
    Segretario
    Cheltenham
    Green Lane
    LE9 8JP Stapleton
    Leicestershire
    British15223990001
    HARRISON, Martin John
    Apartment 48 Lexington Place
    9 Plumtree Street
    NG1 1AN Nottingham
    Segretario
    Apartment 48 Lexington Place
    9 Plumtree Street
    NG1 1AN Nottingham
    BritishDirector93786340001
    HODGES, Stephen
    64 Nield Road
    UB3 1SG Hayes
    Middlesex
    Segretario
    64 Nield Road
    UB3 1SG Hayes
    Middlesex
    British91088020001
    MCLEOD, Alexander John
    54 Catkin Way
    New Balderton
    NG24 3DT Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    54 Catkin Way
    New Balderton
    NG24 3DT Newark
    Nottinghamshire
    British60523570002
    BELL, Alastair Thomas Graham
    14 Greenburn Close
    Gamston
    NG2 6QL Nottingham
    Amministratore
    14 Greenburn Close
    Gamston
    NG2 6QL Nottingham
    EnglandBritishDirector227317270001
    CAMMACK, Nicholas James
    297a High Road
    Chilwell
    NG9 5DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    297a High Road
    Chilwell
    NG9 5DD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishFinance Director114260730001
    CHAMBERS, Craig Stephen
    1 British Gypsum Limited
    East Leake
    LE12 6HX Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    1 British Gypsum Limited
    East Leake
    LE12 6HX Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector124421960001
    COULSON, Clifford Beeby
    Cheltenham
    Green Lane
    LE9 8JP Stapleton
    Leicestershire
    Amministratore
    Cheltenham
    Green Lane
    LE9 8JP Stapleton
    Leicestershire
    BritishManaging Director15223990001
    COULSON, Hazel Agnes
    Cheltenham
    Green Lane
    LE9 8JP Stapleton
    Leics
    Amministratore
    Cheltenham
    Green Lane
    LE9 8JP Stapleton
    Leics
    BritishHousewife18966290001
    DOLAN, Brian Gerard
    British Gypsum Limited
    Head Office, East Leake
    LE12 6HX Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    British Gypsum Limited
    Head Office, East Leake
    LE12 6HX Loughborough
    Leicestershire
    IrishFinance Director81539430003
    HEARD, Robert Michael
    Birkdale 11 Westfield Road
    HP9 1EG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Birkdale 11 Westfield Road
    HP9 1EG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Secretary3862840002
    IZZARD, Stephen Garry
    2 Beaver Close
    Whetstone
    LE8 6ZX Leicester
    Amministratore
    2 Beaver Close
    Whetstone
    LE8 6ZX Leicester
    BritishDirector43883390001
    JONES, David Michael
    16a La-Kris Tower
    9 Skyhumvit 50 133
    FOREIGN Bangkok
    Thailand
    Amministratore
    16a La-Kris Tower
    9 Skyhumvit 50 133
    FOREIGN Bangkok
    Thailand
    BritishMarketing Director48090740002
    LAMBERT, Thierry
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Merchant House
    United Kingdom
    Amministratore
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Merchant House
    United Kingdom
    FrenchDeputy General Delegate136578380002
    LAZARD, Roland, Mr.
    Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HQ London
    Amministratore
    Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HQ London
    FrenchGeneral Delegate105253300003
    WELCH, Robert John
    52 Ripley Gardens
    SW14 8HF London
    Amministratore
    52 Ripley Gardens
    SW14 8HF London
    BritishChartered Secretary68268800002
    WITHERS, Paul Nigel, Dr
    Old Whitehill Barn
    Old Whitehill, Tackley
    OX5 3AB Kidlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Old Whitehill Barn
    Old Whitehill, Tackley
    OX5 3AB Kidlington
    Oxfordshire
    United KingdomBritishBusiness Development Director70021940001

    PROFILEX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 1991
    Consegnato il 01 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings situate in dodwells road, dodwells ind est hinkley, leics. T/no. Lt 214969 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 set 1988
    Consegnato il 21 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Dodwells road, dodwells industrial estate, hinckley, leicestershire t/n lt 169530 and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 21 giu 1988
    Consegnato il 22 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as plots la and la extension dodwells bridge industrial estate, hinckley, leicestershire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 nov 1987
    Consegnato il 16 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PROFILEX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 set 2010Inizio della liquidazione
    23 ago 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Nigel Heath Sinclair
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0