HELENA PRODUCTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HELENA PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02163283 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ROYSCOT CORPORATE LEASING LIMITED | 18 ago 1989 | 18 ago 1989 |
| ROYSCOT GLYN'S LIMITED | 18 mag 1989 | 18 mag 1989 |
| ENTERCARE LIMITED | 11 set 1987 | 11 set 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Modifica dei dettagli di P of a Productions Limited come persona con controllo significativo il 12 apr 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 18 pagine | AA | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2019 al 31 dic 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Notifica di P of a Productions Limited come persona con controllo significativo il 11 lug 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione di Royal Bank Leasing Limited come persona con controllo significativo il 11 lug 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Cessazione della carica di Stephen Paul Nixon come amministratore in data 26 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Simon Charles Lowe come amministratore in data 26 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Quadrangle the Promenade Cheltenham, Gloucestershire GL50 1PX a 250 Bishopsgate London London EC2M 4AA in data 12 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Natwest Markets Secretarial Services Limited come segretario in data 27 mar 2019 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Rbs Secretarial Services Limited come segretario in data 27 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2018 | 20 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Ian Andrew Ellis come amministratore in data 08 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Keith Damian Pereira come amministratore in data 08 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Stephen Paul Nixon come amministratore in data 08 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Steven James Roulston come amministratore in data 08 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di David Gerald Harris come amministratore in data 08 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MARKETS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England |
| 249447430001 | ||||||||||
| LOWE, Simon Charles | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | 109835010002 | |||||||||
| PEREIRA, Keith Damian | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 239981580001 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Segretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Segretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| LEA, John Albert | Segretario | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | 1369400003 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Segretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24-25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| BROWN, Martin Graham | Amministratore | Blueboys Barn Cirencester Road GL6 9EQ Minchinhampton Gloucestershire | British | 36168760001 | ||||||||||
| CARR, Thomas | Amministratore | 4 Admirals Court Eastbury Avenue HA6 3JP Northwood Middlesex | British | 656980011 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Amministratore | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Amministratore | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Amministratore | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Amministratore | The Quadrangle, The Promenade, Cheltenham, Glos, Gl50 1px. | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| CROME, Trevor Douglas | Amministratore | The Quadrangle, The Promenade, Cheltenham, Glos, Gl50 1px. | England | British | 186705800001 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Amministratore | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| ELDER, Davies Burns | Amministratore | Flat 9 Cathedral Lodge 110-115 Aldersgate Street EC1A 4JE London | British | 70027580001 | ||||||||||
| ELLIS, Ian Andrew | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 243996550001 | |||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Amministratore | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| FLINT, Eion Arthur Mcmorran | Amministratore | The Rhododendrons Warren Lane Finchampstead RG40 4HS Wokingham Berkshire | British | 56760630002 | ||||||||||
| FREEBOROUGH, Christopher Rupert | Amministratore | The Malthouse The Green Sheepscombe GL6 7RG Stroud Gloucestershire | British | 68451360002 | ||||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Amministratore | The Quadrangle, The Promenade, Cheltenham, Glos, Gl50 1px. | England | British | 74834980002 | |||||||||
| HARRIS, David Gerald | Amministratore | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 236842580001 | |||||||||
| JOHNSON, Alan Piers | Amministratore | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | 155895050001 | |||||||||
| LATTER, William Vaughan | Amministratore | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| MAYES, Emma-Marie | Amministratore | The Promenade GL50 1PX Cheltenham, The Quadrangle Gloucestershire | United Kingdom | British | 258397370001 | |||||||||
| MCDAID, Neil Jason | Amministratore | EC2M 4RB London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | 222279310001 | |||||||||
| NIXON, Stephen Paul | Amministratore | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 | England | British | 161010580001 | |||||||||
| PEARCE, Nigel | Amministratore | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| ROGERS, Julian Edwin | Amministratore | 2 The Green RM15 6SD South Ockendon Nubbock House Essex England | England | British | 137180040001 | |||||||||
| ROULSTON, Steven James | Amministratore | Ground Floor, Business House F EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn, PO BOX 1000 Scotland | Scotland | British | 238205130001 | |||||||||
| SHEPHARD, Ian Maxwell | Amministratore | Hungerford House Pale Lane Winchfield RG27 8SW Hook Hampshire | British | 111421920002 | ||||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Amministratore | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Amministratore | 10 Berberry Drive MK45 5ER Flitton Bedforedshire | England | British | 111421900001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HELENA PRODUCTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Of A Productions Limited | 11 lug 2017 | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Royal Bank Leasing Limited | 06 apr 2016 | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HELENA PRODUCTIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 02 feb 2004 Consegnato il 20 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right title and interest in the literary property, copyrights, music, ancillary rights, exploitation rights, accounts receivables, commitments, contract rights, insurance, trademarks, title ect, income sources, other intangibles, equipment, property and other physical property, books records and access rights, other property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of security assignment and charge | Creato il 17 apr 2003 Consegnato il 02 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all right title and interest in and to the entire copyright and all other rights in and to the film (entitled "troy") and all elements contained therein. The rights of copyright and other rights in all underlying material acquired or created by the company to enable the film to be produced and exploited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0