CARE ESTATES LIMITED

CARE ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARE ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02164665
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARE ESTATES LIMITED?

    • (5510) /

    Dove si trova CARE ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Rivergate Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARE ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per CARE ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 26 set 2016

    55 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 26 set 2016

    55 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2016

    55 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 29 feb 2016

    42 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2015

    51 pagine2.24B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Avviso di decadenza dall'incarico da parte dell'amministratore

    7 pagine2.39B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2015

    51 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    55 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2014

    55 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2014

    56 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2013

    66 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2012

    63 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2013

    64 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 mar 2012

    69 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 set 2011

    65 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 mag 2011

    67 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Derek Purvis come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Gate House Avonpark Village Winsley Hill Limpley Stoke Bath BA2 7NU* in data 24 gen 2011

    2 pagineAD01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Chi sono gli amministratori di CARE ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURGESS, Anthony John
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant43144030004
    BURGESS, Anthony John
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant43144030004
    COOPER, Hudson Findlay
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Amministratore
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    United KingdomSouth AfricanDirector33695190004
    HALL, Sally Janet
    Lakeside
    Chapel Road Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Segretario
    Lakeside
    Chapel Road Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    BritishAccounts Administrator36750830002
    PURVIS, Derek
    18 Tavinor Drive
    Pewsham
    SN15 3FU Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    18 Tavinor Drive
    Pewsham
    SN15 3FU Chippenham
    Wiltshire
    British74444890001
    M & N SECRETARIES LIMITED
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    Segretario
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    74919560014
    M & N SECRETARIES LIMITED
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    Segretario nominato
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    900001060001
    COOPER, James Findlay
    5 Lower Street
    Rode
    BA11 6PU Frome
    Brooklea
    Somerset
    Amministratore
    5 Lower Street
    Rode
    BA11 6PU Frome
    Brooklea
    Somerset
    United KingdomBritishCare Homes129881120001
    HARPER, Catherine Denise
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Amministratore
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    BritishNursing Home Director44904500006
    MARCHANT, Keith George
    39 Higham Lane
    TN10 4JE Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    39 Higham Lane
    TN10 4JE Tonbridge
    Kent
    BritishDirector1637780001

    CARE ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 09 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 09 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as land forming part of winsley sanitorium winsley title number WT79461. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Shares mortgage
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) the original securities (ii) the additional securities, and (iii) all related rights in respect of the original securities and the additional securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 1996
    Consegnato il 18 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party deed of charge over securities
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 12 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from beam hazel limited,avonpark care centre limited,avonpark retirement centre limited the company or any other person who is a party to any related security document to the chargee under or pursuant to the terms of the facility agreements the charge or any related security document or on any account whatsoever.(all definitions as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over all the company`s present and future rights title and interest in and to: all the ordinary shares of £1.00 each in avonpark estates management limited together with all other shares issued by aeml that constitute the issued share capital of aeml now or from time to time held by the company and being at the date hereof 2 ordinary shares of £1.00 each legally and beneficially owned by the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 1990
    Consegnato il 26 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Winsley sanatorium winsley in the county of wilts, title no wt 79461 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 1990
    Consegnato il 26 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floating charge over the undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 set 1988
    Consegnato il 06 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that f/h property k/a winsley sanatorium winsley, wiltshire & all buildings trade fixtures fixed plant & machinery floating charge over the undertaking and all property and assets present and future (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Limited
    Transazioni
    • 06 set 1988Registrazione di un'ipoteca

    CARE ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 nov 2010Inizio dell'amministrazione
    26 set 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Praticante
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Robin David Allen
    3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Praticante
    3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0