DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED

DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02166971
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHELSFIELD (BOND STREET) LIMITED02 mar 199402 mar 1994
    C.S. (BOND STREET) LIMITED12 feb 199112 feb 1991
    CHELSFIELD ESTATES LIMITED30 nov 198730 nov 1987
    JETCRUCIAL LIMITED18 set 198718 set 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Malcolm Robin Turner come amministratore in data 19 gen 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2016

    Stato del capitale al 12 gen 2016

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    14 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    9 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    capital

    Risoluzioni

    Company business 14/02/2013
    RES13

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2015

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di John Anthony Corcoran come amministratore in data 07 nov 2014

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    6 pagineSH19

    legacy

    CAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2014

    Stato del capitale al 06 gen 2014

    • Capitale: GBP 4,354
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Ms Megan Joy Langridge come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di E L Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    14 pagineAA

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Chi sono gli amministratori di DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANGRIDGE, Megan Joy
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    173435070001
    CORCORAN, John Anthony
    Alexander Square
    SW3 2AN London
    23
    England
    England
    Amministratore
    Alexander Square
    SW3 2AN London
    23
    England
    England
    EnglandAustralian192929620001
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    EnglandIrish75571770001
    COOK, Kenneth Alan
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    Segretario
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    British100000003
    HARRISON, Linda Christine
    87 Kimberley Road
    CR0 2PZ Croydon
    Surrey
    Segretario
    87 Kimberley Road
    CR0 2PZ Croydon
    Surrey
    British85883750001
    OSBORNE, Ian
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    Segretario
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    British44830690006
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Segretario
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    BARROTT, Ronald Stephen
    5 Woolfe Court
    Northwick Park Blockley
    GL56 9RS Moreton In The Marsh
    Amministratore
    5 Woolfe Court
    Northwick Park Blockley
    GL56 9RS Moreton In The Marsh
    British103108860001
    BERNERD, Elliott
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    Amministratore
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    British44790970001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Amministratore
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    British2996750001
    BUTLER, Robin Elliott
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish2996760007
    FUJIOKA, Mikihisa
    31 Heath Rise
    SW15 3HF London
    Amministratore
    31 Heath Rise
    SW15 3HF London
    Japanese30529330001
    HUGILL, William Nigel
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    Amministratore
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    EnglandBritish3015960006
    ICHIMIYA, Masami
    54 Queen Elizabeth Drive
    Southgate
    N14 6RD London
    Amministratore
    54 Queen Elizabeth Drive
    Southgate
    N14 6RD London
    Japanese39355660002
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Australian108719480001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Amministratore
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    EnglandFrench99292580003
    NAKAJIMA, Hirokazu
    11-8 64 Buckingham Gate
    Westminster
    SW1 London
    Amministratore
    11-8 64 Buckingham Gate
    Westminster
    SW1 London
    Japanese32421790001
    NATHAN, Timothy Paul
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    Amministratore
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    United KingdomBritish104162560001
    PEDERSEN, Karen Maree
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Amministratore
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Australian109087760001
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Amministratore
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritish65062400001
    SHAW, John Campbell
    Park House 2 John Woolf Court
    Northwick Park
    GL56 9RS Blackley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Park House 2 John Woolf Court
    Northwick Park
    GL56 9RS Blackley
    Gloucestershire
    British104735000001
    TURNER, Malcolm Robin
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritish60293070008

    DUELGUIDE (BOND STREET) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 17 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first priority legal mortgage all estates or interests in any freehold or leasehold property owned by it by way of a first priority legal mortgage all rights and interests owned by it in the global switch limited partnership. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2002
    Consegnato il 26 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Luxembourg S.A. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 26 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 17 ott 2002
    Consegnato il 25 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee as agent and trustee for the finance parties (the "agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 2001
    Acquisito il 17 ott 2002
    Consegnato il 26 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Leasehold property global switch london (formerly east india dock house), east india dock, london t/n EGL285938. The shares and all related rights. For further details please refer to form 400.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Luxembourg S.A. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 26 ott 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 31 ago 2001
    Acquisito il 17 ott 2002
    Consegnato il 26 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and all related rights by way of equitable mortgage or second fixed charge. For further details please refer to form 400.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Luxembourg S.A. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 26 ott 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First and third party legal charge
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 11 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as part basement, part ground, part 1ST floor and part 2ND floor westbury hotel conduit street and new bond street, london W1 30.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 1997
    Consegnato il 15 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a new bond street house 1-5 new bond street 1 burlington gardens and 15-17 cork street t/no;-387078 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 1996
    Consegnato il 23 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a new bond street house 1-5 new bond street 1 burlington gardens and 15-17 cork street t/no 387078 with all proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security of interest rate cap agreement
    Creato il 12 ott 1995
    Consegnato il 13 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a debenture dated 7TH july 1995 (as amended, varied, supplemented, novated or replaced from time to time)
    Brevi particolari
    Assigns all rights interest and entitlements under the interest rate cap agreement (ref: 5806) dated 17 july 1995. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 05 ott 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7 july 1995
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the contracts as detailed on the schedule to form 395 all dated 14 september 1995. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security
    Creato il 07 lug 1995
    Consegnato il 12 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 7TH july 1995 (as amended, varied, novated or supplemented from time to time)
    Brevi particolari
    Rights title & interest in the contracts inc, all claims thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 1995
    Consegnato il 12 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a new bond street house 1-5 new bond street 1 burlington gardens and 15-17 cork street t/no 387078. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 mar 1991
    Consegnato il 22 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 5TH march 1991 and the deed of charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • SC Investment (UK) Limited
    Transazioni
    • 22 mar 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 mar 1991
    Consegnato il 07 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement of even date and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Sumitomo Trust Co Banking Co LTD.
    Transazioni
    • 07 mar 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of account
    Creato il 05 mar 1991
    Consegnato il 07 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 5TH march 1991 the security documents (including this assignment of evan date
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest in the account (please see doc M395 tc ref M17C for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Sumitomo Trust Co Banking Co. LTD.
    Transazioni
    • 07 mar 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1989
    Consegnato il 29 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    New bend st house burlington gardens l/b of city of westminster title no 387078.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 14 dic 1989
    Consegnato il 22 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the undertaking all propety and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0