BURTON MCCALL LIMITED

BURTON MCCALL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBURTON MCCALL LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02168907
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BURTON MCCALL LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova BURTON MCCALL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BURTON MCCALL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    G.D. IMPORTS LIMITED15 ott 198715 ott 1987
    FIRSTKEEN LIMITED24 set 198724 set 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di BURTON MCCALL LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BURTON MCCALL LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per BURTON MCCALL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Bailey Court Green Street Macclesfield Cheshire SK10 1JQ a 3 Bailey Court Green Street Macclesfield SK10 1JQ in data 09 mar 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Ian Michael Bickerstaffe come amministratore in data 31 dic 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2016

    Stato del capitale al 03 mag 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mrs Michelle Ann Dickinson come amministratore in data 15 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael John Millner Edwards come amministratore in data 15 mar 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Cann il 03 feb 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA

    Secondo deposito di TM01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    2 pagineRP04
    Note
    DataNota
    21 lug 2015Clarification This document is a second filing of the TM01 registered on 19/05/2015 for Beverley John Berryman

    Chi sono gli amministratori di BURTON MCCALL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOPER, Christopher
    7 Heddington Close
    West Knighton
    LE2 6HE Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    7 Heddington Close
    West Knighton
    LE2 6HE Leicester
    Leicestershire
    British117549120001
    CANN, Stephen James
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4 Bailey Court
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4 Bailey Court
    Cheshire
    England
    EnglandBritishAccountant33849510008
    COOPER, Christopher
    Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4
    Cheshire
    Amministratore
    Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4
    Cheshire
    EnglandBritishFinance And Operations Director151873800001
    DICKINSON, Michelle Ann
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    3 Bailey Court
    England
    Amministratore
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    3 Bailey Court
    England
    United KingdomBritishDirector158638390001
    CANN, Stephen James
    The White House
    Clarke Lane
    SK11 0NE Langley
    Cheshire
    Segretario
    The White House
    Clarke Lane
    SK11 0NE Langley
    Cheshire
    BritishAccountant33849510007
    GAMBLE, Diane Kay
    Braywick 1 South Walk
    PO22 7RW Bognor Regis
    West Sussex
    Segretario
    Braywick 1 South Walk
    PO22 7RW Bognor Regis
    West Sussex
    American5791640001
    KHAKHAR, Alpesh
    14 Sandown Road
    LE18 1LD Wigston Fields
    Sandown House
    Leicestershire
    England
    Segretario
    14 Sandown Road
    LE18 1LD Wigston Fields
    Sandown House
    Leicestershire
    England
    BritishAccountant166582980001
    BERRYMAN, Beverly John
    Halfway House
    92 Fishpool Street
    AL3 4RX St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Halfway House
    92 Fishpool Street
    AL3 4RX St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGroup Chief Executive36666480006
    BICKERSTAFFE, Ian Michael
    Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4
    Cheshire
    Amministratore
    Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4
    Cheshire
    United KingdomBritishCertified Chartered Accountant199390540001
    BRENNAN, Mark Simon
    Holly Cottage
    Nortoft
    NN6 8QB Guilsborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    Holly Cottage
    Nortoft
    NN6 8QB Guilsborough
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector300251250001
    DAVEY, Steven John
    17 Damson Close
    NN14 4RG Thrapston
    Northamptonshire
    Amministratore
    17 Damson Close
    NN14 4RG Thrapston
    Northamptonshire
    EnglandBritishManaging Director73143800001
    EDWARDS, Michael John Millner
    Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4
    Cheshire
    Amministratore
    Bailey Court
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director199433780001
    GAMBLE, Diane Kay
    Braywick 1 South Walk
    PO22 7RW Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    Braywick 1 South Walk
    PO22 7RW Bognor Regis
    West Sussex
    AmericanCompany Director5791640001
    GAMBLE, John
    Braywick 1 South Walk
    PO22 7RW Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    Braywick 1 South Walk
    PO22 7RW Bognor Regis
    West Sussex
    AmericanCompany Director5791650001
    KEMP, Jonathan Michael
    9 Deer Leap
    GU18 5PF Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    9 Deer Leap
    GU18 5PF Lightwater
    Surrey
    BritishSales78163480001
    KHAKHAR, Alpesh
    14 Sandown Road
    LE18 1LD Wigston Fields
    Sandown House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    14 Sandown Road
    LE18 1LD Wigston Fields
    Sandown House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishAccountant166582980001
    SHAW, Adrian Lindsey
    13 Wednesday Market
    HU17 0DH Beverley
    North Humberside
    Amministratore
    13 Wednesday Market
    HU17 0DH Beverley
    North Humberside
    BritishDirector47427780003
    WALMSLEY, David Loynds
    Robin Hill
    Mellor Brow Mellor
    BB2 7EX Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    Robin Hill
    Mellor Brow Mellor
    BB2 7EX Blackburn
    Lancashire
    BritishCertified Accountant Chartered Secretary1803800001
    WALTERS, Philip John
    Green Fields
    Minn Bank Willoughbridge
    TF9 4JQ Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Green Fields
    Minn Bank Willoughbridge
    TF9 4JQ Market Drayton
    Shropshire
    BritishDirector58649430001
    WINDLE, Stephen Roger
    Bramley House
    Highstreet
    NG13 9NU Orston
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Bramley House
    Highstreet
    NG13 9NU Orston
    Nottinghamshire
    BritishNone69661840002

    Chi sono le persone con controllo significativo di BURTON MCCALL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bollin Group Limited
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4 Bailey Court
    England
    06 apr 2016
    Green Street
    SK10 1JQ Macclesfield
    4 Bailey Court
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies England And Wales
    Numero di registrazione2404333
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BURTON MCCALL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 feb 2014
    Consegnato il 19 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001 and
    Creato il 27 ago 2009
    Consegnato il 28 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 16 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 2008
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001 and
    Creato il 09 mag 2007
    Consegnato il 26 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission (to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001)
    Creato il 09 ago 2004
    Consegnato il 20 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 14/08/2001
    Creato il 15 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 22 feb 1994
    Consegnato il 02 mar 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 1990
    Consegnato il 17 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 1 & 2 & 3 middleton business park yapton road middleton on sea bognor regis west sussex title no 152642.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 feb 1988
    Consegnato il 02 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0