EUROCUT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEUROCUT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02172710
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EUROCUT LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova EUROCUT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    HAWSONS
    Pegasus House 463a Glossop Road
    S10 2QD Sheffield
    South Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EUROCUT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per EUROCUT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Cessazione della carica di Michael Mason come amministratore

    2 pagineTM01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2010

    Stato del capitale al 02 feb 2010

    • Capitale: GBP 70,500
    SH01

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 30 giu 2007

    17 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    4 pagine395

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(287)

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    9 pagine155(6)a

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Chi sono gli amministratori di EUROCUT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADLEY, Felicity Ann
    212 Derbyshire Lane
    S8 8SE Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    212 Derbyshire Lane
    S8 8SE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishAccountant126805180001
    EARL, Stanley Rylatt
    2 Stockwell Road
    HG5 0JN Knaresborough
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Stockwell Road
    HG5 0JN Knaresborough
    North Yorkshire
    British2212840001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Segretario
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    MASON, Mike
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary102494410001
    RYLETT, Colin Lee
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    British70442720002
    WESTWOOD, Stephen
    2 Devonshire Close
    Dore
    S17 3NX Sheffield
    Segretario
    2 Devonshire Close
    Dore
    S17 3NX Sheffield
    BritishCompany Director7264410001
    BENNETT, Raymond Allen
    8 Baldersdale Avenue
    HG5 0HH Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    8 Baldersdale Avenue
    HG5 0HH Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishProduction Director116142920001
    KEMP, Gerard Alan
    Mill Farm
    Alne
    YO6 2JE York
    Yorkshire
    Amministratore
    Mill Farm
    Alne
    YO6 2JE York
    Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director2212860001
    MASON, Michael
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Malting Close
    Robin Hood
    WF3 3AN Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director111015690001
    MCGRATH, Elaine
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    BritishBuilding Society Manager22037770001
    MCGRATH, Sean Francis
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    BritishProduction Director18633970001
    MILLER, Christopher Hugh
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    Amministratore
    2 Rushcliffe Avenue
    Radcliffe On Trent
    NG12 2AF Nottingham
    EnglandBritishDirector8071340001
    OGDEN, Gary Miles
    2 Fountain Court
    Rossington
    DN11 0FS Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Fountain Court
    Rossington
    DN11 0FS Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandEnglishAccountant48377660003
    RYLETT, Colin Lee
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    8 Copper Beech Close
    Beighton
    S20 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    BritishAccountant70442720002
    SHAW, Stephen Martin
    13 Wollaton Road
    S17 4LD Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    13 Wollaton Road
    S17 4LD Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director78291310001
    STAMP, Kevin
    57 Greenhead Gardens
    Chapeltown
    S35 1AR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    57 Greenhead Gardens
    Chapeltown
    S35 1AR Sheffield
    South Yorkshire
    BritishTechnical Director69912990001
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    Amministratore
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritishManagement Consultant26617400002

    EUROCUT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge document
    Creato il 12 feb 2008
    Consegnato il 29 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    £17,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The plant and machinery detailed in schedule one of the loan agreement and attached to the charge documentation between the medical houes PLC and eurocut limited dated 12TH feb 2008.
    Persone aventi diritto
    • The Medical House PLC
    Transazioni
    • 29 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Loan agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    £50,000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    All rights over the plant machinery and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Medical House PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2007
    Consegnato il 09 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    £2,901,188.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The factory and warehouse premises at 201 newhall road, sheffield and the whitehouse building, liverpool street, sheffi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Medical House PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 13 set 2006
    Consegnato il 22 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment jones and shipman cylindrical grinder with digital readouts s/no 22000BO73989 model 1076E14 dtm rapid prototyping machine s/no 139181.33GO1011530 model sinerstation 2500 plus - with laser upgrade bridgeport vertical centre cnc s/no 601532531122 model VMC6009 (for details of further chattels charged please refer to the form 395 to) together with all replacements and all right title interest and benefit in and to any warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 ago 2004
    Consegnato il 28 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 03 apr 2003
    Consegnato il 05 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Schutte N50 cnc 3 y grinder series 51 NO23 (1993), schutte wu 400 cnc 4 axis tool grinder series 07 NO04 (1993), schutte cnc 5 axis machine series 08 NO06 (1994) (please refer to form 395 for further details). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 03 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 12 gen 1988
    Consegnato il 20 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0