BWS CYMRU CYFYNGEDIG

BWS CYMRU CYFYNGEDIG

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBWS CYMRU CYFYNGEDIG
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02173039
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BWS CYMRU CYFYNGEDIG?

    • (6021) /

    Dove si trova BWS CYMRU CYFYNGEDIG?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BWS CYMRU CYFYNGEDIG?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEXTCITY LIMITED23 feb 198923 feb 1989
    ATL (WESTERN) LIMITED29 feb 198829 feb 1988
    NEXTCITY LIMITED01 ott 198701 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di BWS CYMRU CYFYNGEDIG?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BWS CYMRU CYFYNGEDIG?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2011

    Stato del capitale al 22 set 2011

    • Capitale: GBP 1,381,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 21 set 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 21 set 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 21 set 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BWS CYMRU CYFYNGEDIG?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Segretario
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Amministratore
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Secretary161250030001
    DODD, John Hamilton
    Staplewood
    Nether Wallop
    SO20 8EQ Stockbridge
    Hampshire
    Segretario
    Staplewood
    Nether Wallop
    SO20 8EQ Stockbridge
    Hampshire
    British3919220001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Segretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director67622780002
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishCompany Director35116070001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director77984700001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director6874440001
    MC ARDLE, Stanley Lawrence
    Barn Ridge Cottage
    Farley
    SP5 1AH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Barn Ridge Cottage
    Farley
    SP5 1AH Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director4644990001
    MCENHILL, Peter Raymond
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    BritishCommerical Executive65346840001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishCompany Secretary48937720001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    BritishGroup Operations Director2719600006

    BWS CYMRU CYFYNGEDIG ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creato il 15 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 04 mag 1994
    Consegnato il 17 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under tyhe terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston("the Agent")
    Transazioni
    • 17 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 dic 1992
    Consegnato il 16 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 dic 1992
    Consegnato il 14 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc for full details .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 14 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 lug 1992
    Consegnato il 04 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M107. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 04 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 mar 1988
    Consegnato il 13 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston.
    Transazioni
    • 13 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BWS CYMRU CYFYNGEDIG ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0