RYSBRIDGE ESTATES LIMITED

RYSBRIDGE ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRYSBRIDGE ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02178607
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PORTRENT LIMITED14 ott 198714 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    39 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 apr 2017

    28 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 apr 2016

    31 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 apr 2015

    33 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 apr 2014

    33 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 179 Great Portland Street London W1W 5LS in data 22 apr 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Cessazione della carica di un amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicolae Christopher Ratiu come amministratore in data 14 feb 2013

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr William Robert Starn come amministratore in data 14 mar 2013

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jagtar Singh come amministratore in data 08 mag 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Gary Balfour-Lynn come amministratore in data 31 mar 2012

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 dic 2011

    Stato del capitale al 13 dic 2011

    • Capitale: GBP 4,400
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2010 al 30 giu 2011

    3 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Blurton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    21 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Francis Blurton il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di RYSBRIDGE ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CITY GROUP PLC
    30 City Road
    EC1Y 2AG London
    Segretario
    30 City Road
    EC1Y 2AG London
    35794270004
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Segretario
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    KARMEL, Simon Harry
    Elm Tree Road
    NW8 9JP London
    20
    Amministratore
    Elm Tree Road
    NW8 9JP London
    20
    EnglandBritish2014130001
    STARN, William Robert
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican154007330001
    LIPSCOMB, Helen
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    Segretario
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    British5036040002
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    WOOLLEY, Roderic Harry
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    Segretario
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    British1017530003
    ARTUS, Alan Norman
    10 Cambridge Road
    SW11 4RS London
    Amministratore
    10 Cambridge Road
    SW11 4RS London
    British72061440002
    AUSTEN, Jonathan Martin
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    Amministratore
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    British36694850001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    BOWES, Graham
    Wavertree
    20 St Peters Road
    TW1 1QX St. Margarets, Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    Wavertree
    20 St Peters Road
    TW1 1QX St. Margarets, Twickenham
    Middlesex
    British37707190003
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Amministratore
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    INGMAN, Philip Michael
    Flat 6 Bridge House
    298 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TT London
    Amministratore
    Flat 6 Bridge House
    298 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TT London
    British54153030001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Amministratore
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    PLUMMER, Jeremy James
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    EnglandBritish3994380002
    POPE, Nigel Howard
    3 Rolleston Close
    Petts Wood
    BR5 1AN Orpington
    Kent
    Amministratore
    3 Rolleston Close
    Petts Wood
    BR5 1AN Orpington
    Kent
    British29583660001
    RATIU, Nicolae Christopher
    47 Clifton Hill
    NW8 0QE London
    Amministratore
    47 Clifton Hill
    NW8 0QE London
    United KingdomBritish67475010001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Amministratore
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SHEEHAN, Nicholas John Philip
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    British39476870001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Amministratore
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SLOAN, Roderick David Gray
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    British9739700002
    STEVENS, Michael
    21 Chestnut Close
    HP6 6EQ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 Chestnut Close
    HP6 6EQ Amersham
    Buckinghamshire
    British60348780001
    TIPPING, Geoffrey Nigel
    The Nursery
    Manningford Abbots
    SN9 5PB Pewsey
    Wiltshire
    Amministratore
    The Nursery
    Manningford Abbots
    SN9 5PB Pewsey
    Wiltshire
    United KingdomBritish80925340001
    WALSH, David George Patrick
    Manor Farm
    Little Cheverell
    SN10 4JP Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Manor Farm
    Little Cheverell
    SN10 4JP Devizes
    Wiltshire
    British11107290001

    RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 lug 2000
    Consegnato il 10 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and any other company named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest in each of the assets: real property, bank accounts, insurances, benefit of licenses consents and authorisations. Floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 10 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All liabilities of the obligors owed or expressed to be owed to the charge (the agent) and to the beneficiaries under or in connection with the finance documents inclcuding principal interest fees costs and expenses and whether owed jointly or severally as principal or surety or in any othr capacity
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 mar 1998
    Consegnato il 27 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for iself and the banks as defined) under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    All real property,any investment,goodwill and uncalled capital,money standing to the credit of any designated account for full details of all charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 27 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 giu 1990
    Consegnato il 03 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company.
    Brevi particolari
    Naval row blackwall way, tower markets, l/b of tower hamlets title no egl 200588 and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 giu 1990
    Consegnato il 03 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company.
    Brevi particolari
    Kensington village avon trading estate aranmore road, l/b of hammersmith & fulham title no ngl 621514 and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 set 1988
    Consegnato il 27 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 dic 1987
    Consegnato il 17 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a land & buildings on the south side of navalrow and on the east side of blackwall way, london E14, title no. Egl 200588.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 22 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 dic 1987
    Consegnato il 17 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a avon trading estate situate at avonmore road fulham, title no. Ngl 125133.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 22 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 apr 2013Inizio della liquidazione
    29 giu 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0