COBRA LONDON MARKETS LIMITED

COBRA LONDON MARKETS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOBRA LONDON MARKETS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02181039
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rossington's Business Park
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COBRA GAL LIMITED22 feb 200622 feb 2006
    G.A.L LIMITED31 ago 200431 ago 2004
    GRIFFITHS & ARMOUR (LONDON) LIMITED11 feb 198811 feb 1988
    NOTIONSURE LIMITED19 ott 198719 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 02 ott 2023

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Cessazione della carica di Adrian Colosso come amministratore in data 25 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Mark Walsh come amministratore in data 25 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy John Chadwick come amministratore in data 25 set 2023

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Chadwick il 27 mar 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Mark Walsh il 28 nov 2019

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Fiona Andrews come amministratore in data 31 dic 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    28 pagineAA

    Cessazione della carica di Brendan James Mcmanus come amministratore in data 30 giu 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ryan Christopher Brown come amministratore in data 30 giu 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard John Scott come amministratore in data 05 gen 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    32 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Cobra Gal (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    31 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2020 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JOHNSON, Paul Mark
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    EnglandBritish213094470001
    REASON, William Raymond
    274 Hunts Cross Avenue
    Woolton
    L25 8QT Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    274 Hunts Cross Avenue
    Woolton
    L25 8QT Liverpool
    Merseyside
    British18554810001
    SPARLING, Ian William
    12 Clavering Gardens
    West Horndon
    CM13 3ND Brentwood
    Essex
    Segretario
    12 Clavering Gardens
    West Horndon
    CM13 3ND Brentwood
    Essex
    British32242170001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    Segretario
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    34893920004
    WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    Segretario
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    111052920001
    ANDREWS, Fiona
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    EnglandBritish264342050001
    BADER, Steven John
    Queenswood Road
    SE23 2QS London
    54
    England
    Amministratore
    Queenswood Road
    SE23 2QS London
    54
    England
    United KingdomBritish218122040001
    BAMFORTH, Stephen Howard
    8 Broadacre Close
    L18 2JW Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    8 Broadacre Close
    L18 2JW Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish41484410002
    BELL, Malcolm Rennison
    Wren Cottage
    313a Petersham Road Ham
    TW10 7DB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Wren Cottage
    313a Petersham Road Ham
    TW10 7DB Richmond
    Surrey
    British38020090001
    BROWN, Ewen Cameron
    110 Fenchurch Street
    London
    EC3M 5JT
    Amministratore
    110 Fenchurch Street
    London
    EC3M 5JT
    UkBritish146910850001
    BROWN, Ryan Christopher
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    United KingdomBritish287066760001
    BURROWS, Stephen Mark
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish13539590001
    CHADWICK, Timothy John
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    EnglandBritish192340400002
    COLOSSO, Adrian
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    EnglandBritish4555310002
    CRISP, Mark Frederick
    Fenchurch Street
    EC3M 5JT London
    110
    Amministratore
    Fenchurch Street
    EC3M 5JT London
    110
    United KingdomBritish172349850001
    DRISCOLL, Kevin Francis
    22 Brimstage Road
    Heswall
    CH60 1XG Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    22 Brimstage Road
    Heswall
    CH60 1XG Wirral
    Merseyside
    British15848270001
    FULLER, Brian Arthur
    Hornigals Farm
    Feering
    CO5 9RS Essex
    Amministratore
    Hornigals Farm
    Feering
    CO5 9RS Essex
    United KingdomUnited Kingdom24297400004
    GOODWIN, Andrew Stephen
    Conifer Close
    RH2 9NN Reigate
    6
    England
    Amministratore
    Conifer Close
    RH2 9NN Reigate
    6
    England
    United KingdomBritish218149930001
    GRAHAM, Andrew Richard
    14 The Firle
    SS16 6NB Basildon
    Essex
    Amministratore
    14 The Firle
    SS16 6NB Basildon
    Essex
    EnglandBritish38020230002
    GRIFFITHS, Robin Mark Hill
    Glan-Y-Wern
    Llandrynog
    LL16 4ET Denbigh
    Clwyd
    Amministratore
    Glan-Y-Wern
    Llandrynog
    LL16 4ET Denbigh
    Clwyd
    WalesBritish4171930001
    HOLLAMBY, Robert Alan
    56 Roxwell Road
    CM1 2ND Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    56 Roxwell Road
    CM1 2ND Chelmsford
    Essex
    Great BritainBritish67584890002
    JENKINS, Ian Trevor
    Eleuthera 56 Lynwood Grove
    BR6 0BH Orpington
    Kent
    Amministratore
    Eleuthera 56 Lynwood Grove
    BR6 0BH Orpington
    Kent
    British41580860001
    JOHNSTONE, Andrew Neil
    Pendower 36 Gayton Lane
    Heswall
    CH60 8PY Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Pendower 36 Gayton Lane
    Heswall
    CH60 8PY Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish15848310001
    LINCOLN, John Edward
    St Martins Lane
    BR3 3XS Beckenham
    6
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    St Martins Lane
    BR3 3XS Beckenham
    6
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish178228000001
    LITTLE, Carol
    Hornigals Farm
    CO5 9RS Feering
    Colchester
    Amministratore
    Hornigals Farm
    CO5 9RS Feering
    Colchester
    British32242180002
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish41693730006
    LOVELADY, Andrew Robert
    24 Esplen Avenue
    Crosby
    L23 2SS Liverpool
    Amministratore
    24 Esplen Avenue
    Crosby
    L23 2SS Liverpool
    British41693730001
    MCMANUS, Brendan James
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    United KingdomBritish128122260001
    MONNICKENDAM, Peter Frederick John
    Oaklands Colemans Lane
    Danbury
    CM3 4DN Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Oaklands Colemans Lane
    Danbury
    CM3 4DN Chelmsford
    Essex
    British24582750002
    MONTGOMERY, Paul David Rae
    Fenchurch Street
    EC3M 5JT London
    110
    Amministratore
    Fenchurch Street
    EC3M 5JT London
    110
    EnglandBritish172349760001
    PARKER, Peter Terence
    150 Foxon Lane
    CR3 5SF Caterham
    Surrey
    Amministratore
    150 Foxon Lane
    CR3 5SF Caterham
    Surrey
    United KingdomBritish21299410001
    PICKERING, Graham Charles
    Mascalls Court Barn
    Mascalls Court Road, Paddock Wood
    TN12 6NB Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Mascalls Court Barn
    Mascalls Court Road, Paddock Wood
    TN12 6NB Tonbridge
    Kent
    British67584830002
    POULTON, Hannah
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    British99706350001
    REASON, William Raymond
    274 Hunts Cross Avenue
    Woolton
    L25 8QT Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    274 Hunts Cross Avenue
    Woolton
    L25 8QT Liverpool
    Merseyside
    British18554810001
    REDING, Jason Robert John
    c/o Cobra
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    11th Floor
    England
    Amministratore
    c/o Cobra
    1 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7AA London
    11th Floor
    England
    EnglandBritish74451100001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    06 apr 2016
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05074528
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    COBRA LONDON MARKETS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 mar 2015
    Consegnato il 26 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 set 2012
    Consegnato il 22 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macquarie Bank Limited
    Transazioni
    • 22 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 06 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 set 2004
    Consegnato il 21 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 22ND august 1990 (the "principal deed") as modified by a deed of variation dated 14TH december 1993 (the "first deed of variation"), issued by the company
    Creato il 14 ott 1999
    Consegnato il 08 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of all costs, charges, expenses and other liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed (as modified); and the payments of all debts and obligations due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions
    Brevi particolari
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyd'sas Trustee for the Creditors for the Time Beingof the Company in Respect of the Insurance Transactions
    Transazioni
    • 08 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 14 dic 1993
    Consegnato il 21 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge created by the deed of variation is a continuing security and shall be a second floating charge and subject to all provisions mutatis mutandis of the security and trust deed (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds as Trustee for Approved Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 21 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security and trust deed
    Creato il 22 ago 1990
    Consegnato il 24 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (see 395 ref m 73 and cont'd sheets for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's (A Statutory Corporation)He Company in Respect of Insurance Transactions.as Trustee for Creditors for the Time Being of T
    Transazioni
    • 24 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 set 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0