COBRA LONDON MARKETS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COBRA LONDON MARKETS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02181039 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Rossington's Business Park West Carr Road DN22 7SW Retford England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COBRA GAL LIMITED | 22 feb 2006 | 22 feb 2006 |
| G.A.L LIMITED | 31 ago 2004 | 31 ago 2004 |
| GRIFFITHS & ARMOUR (LONDON) LIMITED | 11 feb 1988 | 11 feb 1988 |
| NOTIONSURE LIMITED | 19 ott 1987 | 19 ott 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 02 ott 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Cessazione della carica di Adrian Colosso come amministratore in data 25 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Mark Walsh come amministratore in data 25 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy John Chadwick come amministratore in data 25 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Chadwick il 27 mar 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Mark Walsh il 28 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fiona Andrews come amministratore in data 31 dic 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Brendan James Mcmanus come amministratore in data 30 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ryan Christopher Brown come amministratore in data 30 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Scott come amministratore in data 05 gen 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 32 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Cobra Gal (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ott 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 31 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2020 al 31 dic 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, Paul Mark | Amministratore | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 213094470001 | |||||
| REASON, William Raymond | Segretario | 274 Hunts Cross Avenue Woolton L25 8QT Liverpool Merseyside | British | 18554810001 | ||||||
| SPARLING, Ian William | Segretario | 12 Clavering Gardens West Horndon CM13 3ND Brentwood Essex | British | 32242170001 | ||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Segretario | Thames House Portsmouth Road KT10 9AD Esher Surrey | 34893920004 | |||||||
| WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 1st Floor Curzon House 24 High Street SM7 2LJ Banstead Surrey | 111052920001 | |||||||
| ANDREWS, Fiona | Amministratore | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 264342050001 | |||||
| BADER, Steven John | Amministratore | Queenswood Road SE23 2QS London 54 England | United Kingdom | British | 218122040001 | |||||
| BAMFORTH, Stephen Howard | Amministratore | 8 Broadacre Close L18 2JW Liverpool Merseyside | England | British | 41484410002 | |||||
| BELL, Malcolm Rennison | Amministratore | Wren Cottage 313a Petersham Road Ham TW10 7DB Richmond Surrey | British | 38020090001 | ||||||
| BROWN, Ewen Cameron | Amministratore | 110 Fenchurch Street London EC3M 5JT | Uk | British | 146910850001 | |||||
| BROWN, Ryan Christopher | Amministratore | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | United Kingdom | British | 287066760001 | |||||
| BURROWS, Stephen Mark | Amministratore | Firdale East Parkside Great Park CR6 9PZ Warlingham Surrey | United Kingdom | British | 13539590001 | |||||
| CHADWICK, Timothy John | Amministratore | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 192340400002 | |||||
| COLOSSO, Adrian | Amministratore | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | England | British | 4555310002 | |||||
| CRISP, Mark Frederick | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 | United Kingdom | British | 172349850001 | |||||
| DRISCOLL, Kevin Francis | Amministratore | 22 Brimstage Road Heswall CH60 1XG Wirral Merseyside | British | 15848270001 | ||||||
| FULLER, Brian Arthur | Amministratore | Hornigals Farm Feering CO5 9RS Essex | United Kingdom | United Kingdom | 24297400004 | |||||
| GOODWIN, Andrew Stephen | Amministratore | Conifer Close RH2 9NN Reigate 6 England | United Kingdom | British | 218149930001 | |||||
| GRAHAM, Andrew Richard | Amministratore | 14 The Firle SS16 6NB Basildon Essex | England | British | 38020230002 | |||||
| GRIFFITHS, Robin Mark Hill | Amministratore | Glan-Y-Wern Llandrynog LL16 4ET Denbigh Clwyd | Wales | British | 4171930001 | |||||
| HOLLAMBY, Robert Alan | Amministratore | 56 Roxwell Road CM1 2ND Chelmsford Essex | Great Britain | British | 67584890002 | |||||
| JENKINS, Ian Trevor | Amministratore | Eleuthera 56 Lynwood Grove BR6 0BH Orpington Kent | British | 41580860001 | ||||||
| JOHNSTONE, Andrew Neil | Amministratore | Pendower 36 Gayton Lane Heswall CH60 8PY Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 15848310001 | |||||
| LINCOLN, John Edward | Amministratore | St Martins Lane BR3 3XS Beckenham 6 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 178228000001 | |||||
| LITTLE, Carol | Amministratore | Hornigals Farm CO5 9RS Feering Colchester | British | 32242180002 | ||||||
| LOVELADY, Andrew Robert | Amministratore | 50 Tollemache Road CH43 8SZ Prenton Merseyside | United Kingdom | British | 41693730006 | |||||
| LOVELADY, Andrew Robert | Amministratore | 24 Esplen Avenue Crosby L23 2SS Liverpool | British | 41693730001 | ||||||
| MCMANUS, Brendan James | Amministratore | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | United Kingdom | British | 128122260001 | |||||
| MONNICKENDAM, Peter Frederick John | Amministratore | Oaklands Colemans Lane Danbury CM3 4DN Chelmsford Essex | British | 24582750002 | ||||||
| MONTGOMERY, Paul David Rae | Amministratore | Fenchurch Street EC3M 5JT London 110 | England | British | 172349760001 | |||||
| PARKER, Peter Terence | Amministratore | 150 Foxon Lane CR3 5SF Caterham Surrey | United Kingdom | British | 21299410001 | |||||
| PICKERING, Graham Charles | Amministratore | Mascalls Court Barn Mascalls Court Road, Paddock Wood TN12 6NB Tonbridge Kent | British | 67584830002 | ||||||
| POULTON, Hannah | Amministratore | 6 Daines Way SS1 3PF Southend On Sea Essex | British | 99706350001 | ||||||
| REASON, William Raymond | Amministratore | 274 Hunts Cross Avenue Woolton L25 8QT Liverpool Merseyside | British | 18554810001 | ||||||
| REDING, Jason Robert John | Amministratore | c/o Cobra 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 11th Floor England | England | British | 74451100001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COBRA LONDON MARKETS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra Gal (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COBRA LONDON MARKETS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 20 mar 2015 Consegnato il 26 mar 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 set 2012 Consegnato il 22 set 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and charge | Creato il 31 mar 2008 Consegnato il 10 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mar 2005 Consegnato il 06 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 set 2004 Consegnato il 21 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 22ND august 1990 (the "principal deed") as modified by a deed of variation dated 14TH december 1993 (the "first deed of variation"), issued by the company | Creato il 14 ott 1999 Consegnato il 08 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of all costs, charges, expenses and other liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed (as modified); and the payments of all debts and obligations due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions | |
Brevi particolari All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation | Creato il 14 dic 1993 Consegnato il 21 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The charge created by the deed of variation is a continuing security and shall be a second floating charge and subject to all provisions mutatis mutandis of the security and trust deed (for full details see form 395). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security and trust deed | Creato il 22 ago 1990 Consegnato il 24 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (see 395 ref m 73 and cont'd sheets for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0