SATELCOM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSATELCOM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02181266
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SATELCOM LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SATELCOM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SATELCOM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SATELCOM (UK) LIMITED18 nov 198718 nov 1987
    ZEDLINES LIMITED20 ott 198720 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di SATELCOM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per SATELCOM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 03 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 03 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    7 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Accounts approved 28/03/2011
    RES13

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jens Peter Montanana il 03 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nigel Vincent Drakford Lewis il 03 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Mark Rogers il 03 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Ian Michael Cook il 03 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Ralph Gerald Maingot il 03 ago 2010

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Richard Starkey il 04 giu 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 28 feb 2009

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SATELCOM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAINGOT, Ralph Gerald
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Segretario
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    British17515310002
    COOK, Ian Michael
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    United KingdomBritish93834540001
    DRAKFORD LEWIS, Nigel Vincent
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritish91208570001
    MONTANANA, Jens Peter
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritish86090220001
    ROGERS, Mark
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    United KingdomBritish109702070001
    STARKEY, Mark Richard
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Amministratore
    110 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritish79610170002
    ASHLEY SECRETARIES LIMITED
    Ashley House
    5 Grosvenor Square
    SO15 2BE Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Ashley House
    5 Grosvenor Square
    SO15 2BE Southampton
    Hampshire
    34342460005
    BISMUT, Philippe Joseph
    6 Rue Lemoine
    FOREIGN Boulogne 92100
    France
    Amministratore
    6 Rue Lemoine
    FOREIGN Boulogne 92100
    France
    FranceFrench124432120001
    CONOLEY, John Richard
    Dromkeen
    Old Compton Lane
    GU9 8EH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Dromkeen
    Old Compton Lane
    GU9 8EH Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish80922910001
    CROIZE-POURCELET, Michel
    58b Rue Des Dessous
    Des Berges Bp 326
    75625 Paris
    Cedex 13 France
    Amministratore
    58b Rue Des Dessous
    Des Berges Bp 326
    75625 Paris
    Cedex 13 France
    French58876640001
    FERRIMAN, Errol Albert
    8 Western Service Road
    Woodmead
    2144 Sandton
    Wendywood
    South Africa
    Amministratore
    8 Western Service Road
    Woodmead
    2144 Sandton
    Wendywood
    South Africa
    South African63876390003
    GEORGE, Ian Robert Leonard
    1 Cottesmore Farm Barns
    Ewelme
    OX10 6HD Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 Cottesmore Farm Barns
    Ewelme
    OX10 6HD Oxford
    Oxfordshire
    British8411570001
    JACOBS, Brian Thomas
    17 Bingham Road
    SP1 2DY Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    17 Bingham Road
    SP1 2DY Salisbury
    Wiltshire
    British15127420001
    JAMES, Jon Stuart
    15 Kemsley Chase
    Farnham Royal
    SL2 3LU Slough
    Berkshire
    Amministratore
    15 Kemsley Chase
    Farnham Royal
    SL2 3LU Slough
    Berkshire
    British63971510001
    LA TROBE BATEMAN, John Frederick
    The Coach House
    Northbrook Avenue
    SO23 0JW Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Coach House
    Northbrook Avenue
    SO23 0JW Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish93597880001
    LAWRENCE, Stephen Francis
    Galloway House
    High Street
    HP7 0ED Old Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Galloway House
    High Street
    HP7 0ED Old Amersham
    Buckinghamshire
    UkBritish292499480001
    MATHIEU, Marc
    41 Cantagrel
    Paris Cedex 14
    France 75631
    Amministratore
    41 Cantagrel
    Paris Cedex 14
    France 75631
    French44601290001
    MCLEOD, Sheila Mary Longden
    Homecroft
    Burbage
    SN8 3RT Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Homecroft
    Burbage
    SN8 3RT Marlborough
    Wiltshire
    British66578400001
    MILLEPIED, Jeans Jacques
    12 Rue Cheret
    FOREIGN 9400 Creteil
    France
    Amministratore
    12 Rue Cheret
    FOREIGN 9400 Creteil
    France
    French29960420001
    MILLER, Andrew Douglas
    37 St James's Avenue
    Hampton Hill
    TW12 1HH Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    37 St James's Avenue
    Hampton Hill
    TW12 1HH Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish86026930001
    NORTH, Simon Anthony
    Cyprus House
    Chesterbalde
    BA4 4QX Shepton Mallet
    Somerset
    Amministratore
    Cyprus House
    Chesterbalde
    BA4 4QX Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish141835720001
    PFAFF, David Brian
    92 East Avenue
    Atholl
    FOREIGN Johannesburg
    South Africa
    Amministratore
    92 East Avenue
    Atholl
    FOREIGN Johannesburg
    South Africa
    South African79445520001
    PITTS, Mark Ian, Vp, Business Development, Vados Solutions
    7 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    7 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritish85473380001
    ROCHESTER, Mervyn Alan
    The Oaks
    16 Iford Gardens
    BH7 6SQ Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    The Oaks
    16 Iford Gardens
    BH7 6SQ Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish96994260001
    VAN DE GEEST, Gerard Peter
    3 The Glebe
    WD4 9HY Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 The Glebe
    WD4 9HY Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish75048910001
    WIBLIN, David
    42 Moor Lane
    WD3 1LG Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    42 Moor Lane
    WD3 1LG Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93597790001

    SATELCOM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 19 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 nov 1997
    Consegnato il 09 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or gateway systems limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of deposit
    Creato il 01 nov 1990
    Consegnato il 19 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    All the interest of satel cam (UK) limited a deposit account held at barclays bank PLC presently in the sum of £43,125.
    Persone aventi diritto
    • Lang Investments (Andover) Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0