WRG PROPERTIES LIMITED

WRG PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWRG PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02181617
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WRG PROPERTIES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova WRG PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WRG PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAIRD PROPERTIES LIMITED21 ott 198721 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di WRG PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per WRG PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG in data 07 dic 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 nov 2012

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2012

    Stato del capitale al 23 lug 2012

    • Capitale: GBP 908,166
    SH01

    Nomina di Mrs Victoria Bunton come segretario in data 26 ott 2011

    1 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Caterina De Feo come segretario

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 24 ago 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Taylor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Meredith come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Leslie Cassells come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di WRG PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUNTON, Victoria
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Segretario
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    164528800001
    FAVIER TILSTON, Claire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British117647490002
    ORTS-LLOPIS, Vicente Federico
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Amministratore
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    United KingdomSpanish147551840001
    TAYLOR, Paul
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Amministratore
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    United KingdomBritish147757950001
    BOLTON, Jonathan Mark
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British15931960007
    CALDER, Samantha Jane
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    British75830790003
    DE FEO, Caterina
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Segretario
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Italian140556050001
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    British34208920001
    HARDMAN, Steven Neville
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    Segretario
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    British93743250001
    KAYE, Paul
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British3245340002
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Segretario
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    British18116420006
    WATERHOUSE, Alan
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    British24588340001
    AVERILL, Michael Charles Edward
    Fir Tree House 61 Chiltern Road
    Long Crendon
    HP18 9BZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fir Tree House 61 Chiltern Road
    Long Crendon
    HP18 9BZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British24913560001
    BURNS, Phillip Wesley
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    Amministratore
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    United KingdomBritish160550800001
    CAMM, Paul Beverley
    18 St Martins Road
    Thorngumbald
    HU12 9PS Hull
    North Humberside
    Amministratore
    18 St Martins Road
    Thorngumbald
    HU12 9PS Hull
    North Humberside
    EnglandBritish14961540001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British95347040005
    COBURN, Paul Michael
    Old Pines, 103, Oldfield Drive
    CH60 9LQ Heswall
    Wirral
    Amministratore
    Old Pines, 103, Oldfield Drive
    CH60 9LQ Heswall
    Wirral
    EnglandBritish113589330001
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Amministratore
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritish37289200002
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish34208920001
    HARDMAN, Steven Neville
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British93743250006
    LINACRE, Peter John
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish34646130002
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Amministratore
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    EnglandBritish18116420006
    STEWART, David John
    7 Lower Brook Lane
    Worsley
    M28 2LL Manchester
    Amministratore
    7 Lower Brook Lane
    Worsley
    M28 2LL Manchester
    British62266560001
    STEWART, Quentin Richard
    The Lodge
    106 Aberdeen Park Islington
    N5 2BA London
    Amministratore
    The Lodge
    106 Aberdeen Park Islington
    N5 2BA London
    British94880800001
    WEIR, David Thomas
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    UkBritish33621820001

    WRG PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Shanks third stage debenture
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 09 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 09 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 05 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of second legal mortgage and second fixed charged the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all the rights and interest present and future in respect of the relevant documents by way of second floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York as Second Secured Note Trustee (The Second Secured Note Trustee)
    Transazioni
    • 05 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of second legal mortgage and second fixed charge the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all its present and future rights and interests in respect of the relevant documents by way of second floating charge, its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York as Second Secured Note Trustee (The "Second Secured Note Trustee")
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shanks third stage debenture
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 21 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 21 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 ago 2004
    Consegnato il 09 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC ("the Security Agent")
    Transazioni
    • 09 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security agent and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ott 1997
    Consegnato il 24 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property's k/a port clarence refinery river tees north bank t/no CE84909 land and buildings lying to the north east of manchester road accrington t/no la 679601 plots 1,2 and 3 waterson industrial estate milford haven t/no wa 486380 and land and buildings lying to the south east of forge lane minworth sutton coldfield t/no wm 427845. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 ott 1988
    Consegnato il 01 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 01 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1988
    Consegnato il 30 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to the south east side of B1273 middleton st. George darlington title no:- du 133312 including all fixtures & fittings (as above). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1988
    Consegnato il 30 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33 sekforde street, london EC1R 0HH title no:- ln 226036 including all fixtures & fittings (other than trade fixtures and fittings) plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit of deeds without written instrument.
    Creato il 02 ago 1988
    Consegnato il 05 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to the south east of the B1273 middleton st george title no:- du 133312 including all fixtures & fittings (other than trade fixtures & fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    98 cheetham hill road manchester title no gm 194892 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Warwick house birmingham road stratford upon avon title no wk 311599 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Units 1/3 100 layton road brentford title no's ngl 562352 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    King charles ii house headlands road pontefract title no. Wyk 240441 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Imperial house 21-25 north street bromley kent title no. Sgl 288719 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    8 a/b & 9 carlton crescent southampton title nos. Hp 167612 & hp 251564 including all fixtures and fittings (ohter than trade fixtures) fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Woodside park somerford booths hall congleton cheshire title no ch 165273 including fixtures and fittings (other than trade fixtures) fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Winterton house high street westerham title nos k 20122 & k 504006 including fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Unit 1/1D swan lane industrial estate title no. Sf 83350 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 02 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from caird group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Unit f consort way burgess hill title no. Wsx 55376 including all fixtures & fittings (other than trade fixtures) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1988
    Consegnato il 15 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    98, cheetham hill road, cheetham manchester, title no:- gm 194892.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1988
    Consegnato il 15 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Teeside training & technology centre, teeside airport, darlington, county durham, title no:- du 133312.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1988
    Consegnato il 15 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33, sekforde street, london EC1, title no:- ln 226036.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1988
    Consegnato il 11 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due to the bank from a caird & sons polc on any account whatsoever and from caird properties limited under the charge
    Brevi particolari
    21/25 north street bromley title no sgl 288719.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1988Registrazione di un'ipoteca

    WRG PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 lug 2013Data di scioglimento
    20 nov 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0