NCN 3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNCN 3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02182323
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NCN 3 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NCN 3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NCN 3 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERON EDUCATIONAL LIMITED15 feb 198815 feb 1988
    SIDEGROWTH LIMITED22 ott 198722 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di NCN 3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NCN 3 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NCN 3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Kowalski il 02 set 2014

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mag 2014

    Stato del capitale al 01 mag 2014

    • Capitale: GBP 4,500
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2013

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Ivan Bolton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2012

    1 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed heron educational LIMITED\certificate issued on 08/08/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name08 ago 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 giu 2012

    RES15
    change-of-name08 ago 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Kowalski il 27 lug 2012

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 27/06/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 apr 2011

    1 pagineAA

    Nomina di Mark Ashcroft come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ivan Bolton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Binns Maudsley il 20 apr 2011

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Credit & supp agre 08/02/2011
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da * Church Bridge House Henry Street Church Accrington Lancashire BB5 4EH United Kingdom* in data 19 gen 2011

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Christopher Hinton come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 apr 2010

    1 pagineAA

    Nomina di Mr Timothy John Kowalski come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Dr Ivan Joseph Bolton come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Burley House Bradford Road Burley in Wharfedale West Yorkshire LS29 7DZ* in data 08 lug 2010

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di NCN 3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165369230001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    UkBritishDirector153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director15967010001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Bracken Hill Odda Lane Hawksworth
    Guiseley
    LS20 8NZ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Bracken Hill Odda Lane Hawksworth
    Guiseley
    LS20 8NZ Leeds
    West Yorkshire
    British14333000007
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Segretario
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    BritishCo Director78151560001
    PIGGOTT, Richard Courtney
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    British112085820001
    PYE, Marian Joy
    Westering Padley Road
    Grindleford
    S30 1HR Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Westering Padley Road
    Grindleford
    S30 1HR Sheffield
    South Yorkshire
    British8037910001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector143093130001
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Amministratore
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritishCo Director78151560001
    FRENCH, Richard Stephen
    14 Waterside Close
    Gamston
    NG2 6QA Nottingham
    Amministratore
    14 Waterside Close
    Gamston
    NG2 6QA Nottingham
    BritishDirector34457710002
    HINTON, Christopher David
    31 Elm Road
    Didsbury
    M20 6XD Manchester
    Amministratore
    31 Elm Road
    Didsbury
    M20 6XD Manchester
    EnglandBritishCompany Director68474940001
    JOHNSON, David Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector157156750001
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Amministratore
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director75327660001
    NEWCOMBE, David Keith
    Middlecroft
    Bredons Norton
    GL20 7HB Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Middlecroft
    Bredons Norton
    GL20 7HB Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector14695610001
    PYE, John Denly
    Westering
    Padley Road, Grindleford
    S32 2HR Hope Valley
    Derbyshire
    Amministratore
    Westering
    Padley Road, Grindleford
    S32 2HR Hope Valley
    Derbyshire
    BritishManaging Director67738210001
    PYE, Marian Joy
    Westering Padley Road
    Grindleford
    S30 1HR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Westering Padley Road
    Grindleford
    S30 1HR Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector8037910001
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    Amministratore
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    BritishCompany Director81630780001
    WIBBERLEY, Nancy
    4 Chapel Mews Court
    Bramcote
    NG9 3HB Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    4 Chapel Mews Court
    Bramcote
    NG9 3HB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishMarketing Manager71740730001

    NCN 3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 24 lug 2009
    Consegnato il 04 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge land investments plant and machinery credit balances insurances other contracts intellectual property its goodwill its uncalled capital floating charge all of its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transazioni
    • 04 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 07 mag 1991
    Consegnato il 16 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Carwood house carwodo road sheepbridge chesterfield debyshire t/no dy 202049 (provisional) and/or the proceeds of sale therof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 feb 1989
    Consegnato il 15 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0