NCN 3 LIMITED
Panoramica
Nome della società | NCN 3 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02182323 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NCN 3 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NCN 3 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 Gregory Street SK14 4TH Hyde Cheshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NCN 3 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HERON EDUCATIONAL LIMITED | 15 feb 1988 | 15 feb 1988 |
SIDEGROWTH LIMITED | 22 ott 1987 | 22 ott 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NCN 3 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 29 mar 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NCN 3 LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per NCN 3 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Kowalski il 02 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ivan Bolton come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed heron educational LIMITED\certificate issued on 08/08/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy John Kowalski il 27 lug 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 apr 2011 | 1 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mark Ashcroft come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ivan Bolton come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Binns Maudsley il 20 apr 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Church Bridge House Henry Street Church Accrington Lancashire BB5 4EH United Kingdom* in data 19 gen 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Hinton come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 apr 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Timothy John Kowalski come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Dr Ivan Joseph Bolton come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Burley House Bradford Road Burley in Wharfedale West Yorkshire LS29 7DZ* in data 08 lug 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di NCN 3 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHCROFT, Mark | Segretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165369230001 | |||||||
KOWALSKI, Timothy John | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | Uk | British | Director | 153335190003 | ||||
MAUDSLEY, Philip Binns | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | Company Director | 15967010001 | ||||
BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Segretario | Bracken Hill Odda Lane Hawksworth Guiseley LS20 8NZ Leeds West Yorkshire | British | 14333000007 | ||||||
DIGHTON, Simon Gerald | Segretario | 28 Lightwoods Hill Bearwood B67 5EA Warley West Midlands | British | Co Director | 78151560001 | |||||
PIGGOTT, Richard Courtney | Segretario | Church House Crown Street Harbury CV33 9HE Leamington Spa Warwickshire | British | 112085820001 | ||||||
PYE, Marian Joy | Segretario | Westering Padley Road Grindleford S30 1HR Sheffield South Yorkshire | British | 8037910001 | ||||||
BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | Director | 14333000007 | ||||
CHAPMAN, Keith | Amministratore | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 143093130001 | ||||
DIGHTON, Simon Gerald | Amministratore | 28 Lightwoods Hill Bearwood B67 5EA Warley West Midlands | United Kingdom | British | Co Director | 78151560001 | ||||
FRENCH, Richard Stephen | Amministratore | 14 Waterside Close Gamston NG2 6QA Nottingham | British | Director | 34457710002 | |||||
HINTON, Christopher David | Amministratore | 31 Elm Road Didsbury M20 6XD Manchester | England | British | Company Director | 68474940001 | ||||
JOHNSON, David Anthony | Amministratore | Cold Knoll Farm Stanbury BD22 0HH Haworth West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 157156750001 | ||||
JOLLY, Patrick Edmund | Amministratore | Hill Top Farm Hill Top Lane Skipton Road, BB18 6JN Earby Lancashire | England | British | Company Director | 75327660001 | ||||
NEWCOMBE, David Keith | Amministratore | Middlecroft Bredons Norton GL20 7HB Tewkesbury Gloucestershire | England | British | Director | 14695610001 | ||||
PYE, John Denly | Amministratore | Westering Padley Road, Grindleford S32 2HR Hope Valley Derbyshire | British | Managing Director | 67738210001 | |||||
PYE, Marian Joy | Amministratore | Westering Padley Road Grindleford S30 1HR Sheffield South Yorkshire | British | Director | 8037910001 | |||||
STOYEL, Rodney | Amministratore | Hambro House Treville Street Roehampton SW15 4JX London | British | Company Director | 81630780001 | |||||
WIBBERLEY, Nancy | Amministratore | 4 Chapel Mews Court Bramcote NG9 3HB Nottingham Nottinghamshire | British | Marketing Manager | 71740730001 |
NCN 3 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Creato il 24 lug 2009 Consegnato il 04 ago 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First fixed charge land investments plant and machinery credit balances insurances other contracts intellectual property its goodwill its uncalled capital floating charge all of its assets see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 07 mag 1991 Consegnato il 16 mag 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Carwood house carwodo road sheepbridge chesterfield debyshire t/no dy 202049 (provisional) and/or the proceeds of sale therof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 09 feb 1989 Consegnato il 15 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0