STROBE 5

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTROBE 5
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02182712
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STROBE 5?

    • (7487) /
    • (7499) /

    Dove si trova STROBE 5?

    Indirizzo della sede legale
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STROBE 5?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STROBE 5 LIMITED29 feb 200829 feb 2008
    NORTHERN LEISURE LIMITED16 lug 200116 lug 2001
    LUMINAR LEISURE LIMITED06 apr 198806 apr 1988
    LEADWISE LEISURE LIMITED26 gen 198826 gen 1988
    LEADWISE LIMITED23 ott 198723 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di STROBE 5?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per STROBE 5?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 mar 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 set 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 mar 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 set 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 14 set 2009

    LRESEX

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    3 pagine288a

    Varie

    Auditor's resignation letter - sec 519
    1 pagineMISC

    Bilancio redatto al 28 feb 2008

    11 pagineAA

    legacy

    6 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return15 set 2008

    legacy

    363(353)
    annual-return15 set 2008

    legacy

    363(190)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem acct 28/02/2008
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Re share premium account 03/03/2008
    RES13

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine122

    Chi sono gli amministratori di STROBE 5?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARDEN, Christian
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    Amministratore
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish62937340001
    BARRETT, David William
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    Amministratore
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    EnglandBritish2264460001
    AUST, Jonathan Neale
    6 Arundel Close
    Sandiacre
    NG10 5PG Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    6 Arundel Close
    Sandiacre
    NG10 5PG Nottingham
    Nottinghamshire
    British28871450001
    KINROSS, John
    6 Handel Mead
    Old Farm Park
    MK7 8QA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    6 Handel Mead
    Old Farm Park
    MK7 8QA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British37384650003
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Segretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British38563740001
    ARNOLD, Michael John
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    British48184650002
    AUST, Jonathan Neale
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    Amministratore
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    EnglandBritish160178570001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Amministratore
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Amministratore
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    EDGE, William
    Triboges House
    Berries Road
    SL6 9SD Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    Triboges House
    Berries Road
    SL6 9SD Cookham
    Berkshire
    British35575760002
    GLYN, Ian Robert Howard
    The Innocents
    OX10 6JR Berrick Salome
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Innocents
    OX10 6JR Berrick Salome
    Oxfordshire
    EnglandBritish4399820001
    HALL, Norman Ronald
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Hartwell Road
    NN7 2NT Roade
    Northamptonshire
    United KingdomBritish98926570001
    LOADES, Stephen
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish77619750001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MARKS, Peter Jack
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish77895710001
    MARSHALL, Anthony
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish155979460001
    MCIVOR, Andrew
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    British61144120003
    MCLOUGHLIN, Brendan Michael
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    Amministratore
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    United KingdomBritish40530320004
    PRESTON, Clive Henry
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Amministratore
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    EnglandBritish1973870004
    ROBERTS, Peter William Denby
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    Amministratore
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    EnglandBritish106538510001
    ROBERTS, Timothy Julian
    Coopers
    Chapel Street
    CV35 9QU Wellesbourne
    Warwickshire
    Amministratore
    Coopers
    Chapel Street
    CV35 9QU Wellesbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritish105669310003
    THOMAS, Stephen Charles
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    Amministratore
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    United KingdomBritish66198390006
    TURVEY, Neil William
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish51899270003
    WILDING, Linda
    Tangley Way
    Blackheath
    GU4 8QS Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Tangley Way
    Blackheath
    GU4 8QS Guildford
    Surrey
    EnglandBritish41193380003
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    WILLITS, Henry Andrew
    Laburnum Cottage
    49 High Street
    LE65 1WJ Packington
    Leicestershire
    Amministratore
    Laburnum Cottage
    49 High Street
    LE65 1WJ Packington
    Leicestershire
    British90132600001

    STROBE 5 ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Licence to assign
    Creato il 12 mar 2009
    Consegnato il 19 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    £37,011.86 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The initial deposit and all money from time to time withdrawn from it see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Trevor Bargh and Alison Jane Bargh
    Transazioni
    • 19 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 15 ago 2007
    Consegnato il 30 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditor
    Transazioni
    • 30 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 09 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future monies debts and liabilities due or to become due from any chargor to the chargee as security trustee (the "security trustee") as security trustee for the benefit of the secured creditors (as defined) in relation to any of the creditor finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1998
    Consegnato il 26 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    62/63 high street maidstone kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1995
    Consegnato il 24 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The properties at 64 and 66 humberstone gate and 10 st james' street leicester t/nos. Lt 57174 and lt 54770.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 08 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a l'aristos, newark road boon gate peterborough t/n cb 104210 and an assignment of all trade and tenant's fixtures fittings and chattels and the goodwill and benefit of all licences held in connection with the business.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 1994
    Consegnato il 14 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old police station queen street colchester essex.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter or the deed both dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Brevi particolari
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.gr 51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mercury Asset Management PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Brevi particolari
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.gr 51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Grosvenor Development Capital PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee a limited partnership acting by its general partner third grosvenor limited under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Brevi particolari
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.gr 51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Third Grosvenor Fund
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as nominee of the second lazard leisure fund acting by its general partner lazard leisure (general partner) limited under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may from time to time be amended) and this legal charge
    Brevi particolari
    All that l/h property forming part of the premises at the leisure centre,station road,gloucester.t/no.GR51238 and all buildings and fixtures fixed plant and machinery.assigns the benefit of all present and future licences.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Funds (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 06 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/as 22 and 22 half silver street, leicester.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 01 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time) and/or a deed dated 20TH january 1993 and other associated charges.
    Brevi particolari
    For full details of properties please see doc M4L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mercury Asset Management PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 01 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time)
    Brevi particolari
    For full details of property please see doc M3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Third Grosvenor Fund
    Transazioni
    • 01 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 01 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time)
    Brevi particolari
    For full details of property charged please see doc M2. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Grosvenor Development Capital PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 01 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20TH january 1993 (as may be varied,supplemented,amended or replaced from time to time)
    Brevi particolari
    For full details of all the property charged please see doc M1. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Funds (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 01 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creato il 04 dic 1992
    Consegnato il 11 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £48,504.20 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Brevi particolari
    All its right,title and interest in and to all sums payable under the insurance.please see doc M387C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 11 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ago 1992
    Consegnato il 10 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH august 1992.
    Brevi particolari
    A)the basement premises with ground floor entrances situate and k/a 20/22 sidney street,cambridge-chicago rock cafe,cambridge.t/no. Cb 577588 for full details of property charged please see doc M7L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mercury Asset Management PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 1991
    Consegnato il 19 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property k/as 20/22 sidney street cambridge title no. Cb 57738.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 1991
    Consegnato il 19 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property situate and k/as part ground floor and basement the royal hotel,norwich.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ago 1991
    Consegnato il 30 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its succennors and assings in accordance with the provisions of a mezzanine loan agreement dated 22/8/91 and other annociated charges.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mercury Asset Management PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 feb 1991
    Consegnato il 12 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property k/as vienna, 63 high street maidstone.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 gen 1991
    Consegnato il 23 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chicago rock 46 park street luton bedfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 apr 1990
    Consegnato il 02 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. Fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Essential Leisure Limited
    Transazioni
    • 02 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STROBE 5 ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 set 2009Inizio della liquidazione
    07 nov 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul John Clark
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0