TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02183136 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PIPECROWN LIMITED | 26 ott 1987 | 26 ott 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 20 nov 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 04 dic 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 20 nov 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Michael Ian Scott come amministratore in data 13 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Michael Ian Scott come amministratore in data 21 ago 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Barbara Mary Richmond come amministratore in data 21 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Helen Davies come amministratore in data 31 lug 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Timothy Huw Stone come amministratore in data 31 lug 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Barratt Corporate Secretarial Services Limited come segretario in data 01 ago 2025 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Bethany Ford come segretario in data 31 lug 2025 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2024 | 1 pagine | AA | ||
Nomina di Mrs Bethany Ford come segretario in data 30 nov 2023 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Graham Anthony Cope come segretario in data 30 nov 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023 | 1 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRATT CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom |
| 160289260001 | ||||||||||
| STONE, Timothy Huw | Amministratore | St David's Park CH5 3RX Flintshire Redrow House United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 297709310001 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Segretario | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | British | 85842880003 | ||||||||||
| EVANS, Stephen Geoffrey | Segretario | The Orchard 58 Huddersfield Road Skelmanthorpe HD8 9AS Huddersfield West Yorkshire | British | 3621900001 | ||||||||||
| FORD, Bethany | Segretario | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | 316534660001 | |||||||||||
| WALKER, Rhiannon Ellis | Segretario | Gatesheath Hall Gatesheath Tattenhall CH3 9AH Chester Cheshire | British | 86070003 | ||||||||||
| BANNISTER, William Henry | Amministratore | 28 Riverside Road West Moors BH22 0LQ Ferndown Dorset | United Kingdom | British | 58990140003 | |||||||||
| BRAND, William John | Amministratore | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | England | British | 5202410003 | |||||||||
| CAMPBELL KELLY, David John | Amministratore | Bridgemere House Yew Tree Close LE8 6BU Willoughby Waterleys Leicestershire | British | 40876330001 | ||||||||||
| DAVIES, Helen | Amministratore | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | United Kingdom | British | 83638070001 | |||||||||
| DAY, Jacqueline May | Amministratore | The Stumps Totteridge Common HP13 7QG High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 42773840001 | |||||||||
| EVANS, Stephen Geoffrey | Amministratore | The Orchard 58 Huddersfield Road Skelmanthorpe HD8 9AS Huddersfield West Yorkshire | England | British | 3621900001 | |||||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | 31 Rean Meadow Tattenhall CH3 9PU Chester Cheshire | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||||||
| FLELLO, Paul Ian | Amministratore | Kingsmead Lodge 7a The Green, Great Horwood MK17 0RH Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 64948520004 | |||||||||
| GIBSON, Barrie John | Amministratore | 14 Kelthorpe Road Ketton PE9 3RS Rutland | United Kingdom | British | 187156090001 | |||||||||
| HADDON, Mark Anthony | Amministratore | 24 Landcross Drive Abington Vale NN3 3LS Northampton Northamptonshire | British | 37400510001 | ||||||||||
| HALL, David George | Amministratore | 7 Octavian Drive Bancroft MK13 0QR Milton Keynes | British | 41519030001 | ||||||||||
| HODGSON, Christopher John | Amministratore | Rose Cottage The Ridge Bossage GL6 8HD Stroud Gloucestershire | England | British | 87716630001 | |||||||||
| LEWIS, Alun Watkin | Amministratore | Pennant 1 Ffordd Dolgoed CH7 1PE Yr Wyddgrug Sir Y Fflint | Wales | British | 37977020001 | |||||||||
| LOCKE, Gregson Horace | Amministratore | North Lea Baker Street OX11 9DD Aston Tirrold Oxfordshire | England | British | 40820130001 | |||||||||
| MAUNDERS, John Ware | Amministratore | Littledown Southdowns Drive Hale WA14 3HR Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 35554380001 | |||||||||
| MICKLEWRIGHT, Graham | Amministratore | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | United Kingdom | British | 98783370001 | |||||||||
| PEAK, James | Amministratore | Adams Lodge 8 Baskerfield Grove Woughton On The Green MK6 3EN Milton Keynes | British | 45884180001 | ||||||||||
| POWELL, Michael Robert | Amministratore | 8 Kentmere Close SK8 4RD Gatley Cheshire | Great Britain | British | 21740050002 | |||||||||
| RICHMOND, Barbara Mary | Amministratore | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | United Kingdom | British | 152559820001 | |||||||||
| SCOTT, Michael Ian | Amministratore | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||||||
| SHAH, Rajesh | Amministratore | 37 Lippitts Hill LU2 7YN Luton Bedfordshire | England | British | 21593270001 | |||||||||
| SMITH, Geoffrey William Craven | Amministratore | Mendips 7 Abbotts Close NN14 3AW Titchmarsh Northamptonshire | British | 81060430001 | ||||||||||
| STEEL, Peter Morgan | Amministratore | 44 Melfort Drive LU7 2XN Leighton Buzzard Bedfordshire | United Kingdom | British | 76534300001 | |||||||||
| STUBBS, Norman Alan | Amministratore | East Chevin Road LS21 3DD Otley The Stables West Yorkshire | England | British | 1692650001 | |||||||||
| SWANSON, John Stewart Richardson | Amministratore | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British | 4946820001 | |||||||||
| TUTTE, John Frederick | Amministratore | Peters Barn West End, Scaldwell NN6 9JX Northampton Northamptonshire | England | British | 56012720002 | |||||||||
| WARRINGTON, Brian | Amministratore | 10 Gilbert Road WA15 9NR Hale Cheshire | British | 65464000002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb (Cpts) Limited | 06 apr 2016 | St. Davids Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0