FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED

FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFITZGEORGE JUNE (1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02184502
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    All Seasons Church Road
    Cookham
    SL6 9PG Maidenhead
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN LEASING JUNE (1) LIMITED30 apr 200130 apr 2001
    KLEINWORT BENSON LEASING JUNE (1) LTD.22 dic 199522 dic 1995
    S.G. WARBURG & CO. (LEASING) (NUMBER 2) LTD.10 mag 198810 mag 1988
    PALLAS LEASING (NUMBER 42) LTD28 ott 198728 ott 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2019

    2 pagineAA

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 nov 2017, non revisionato

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2016

    2 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2017 al 30 nov 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2016

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2016

    Stato del capitale al 09 mar 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Cessazione della carica di Jill Louise Robinson come amministratore in data 15 dic 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jill Louise Robinson come segretario in data 15 dic 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ron Woods come segretario in data 09 mar 2016

    2 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG England a All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG in data 09 mar 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2015

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da The Courtlands 8 Plymouth Drive Barnt Green Worcestershire B45 8JB a All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG in data 09 mar 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 feb 2015

    Stato del capitale al 19 feb 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2014

    Stato del capitale al 01 apr 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2012

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOODS, Ron
    Church Road
    Cookham
    SL6 9PG Maidenhead
    All Seasons
    Berkshire
    England
    Segretario
    Church Road
    Cookham
    SL6 9PG Maidenhead
    All Seasons
    Berkshire
    England
    205931680001
    WOODS, Ronald Ernest
    Church Road
    Cookham
    SL6 9PG Maidenhead
    All Seasons
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Church Road
    Cookham
    SL6 9PG Maidenhead
    All Seasons
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish149388120001
    AMEY, Michelle
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    Segretario
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    British57746950002
    CLIFTON, Roger Cheston
    8 Sandy Close
    GU22 8BQ Woking
    Surrey
    Segretario
    8 Sandy Close
    GU22 8BQ Woking
    Surrey
    British8089410002
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    LAYCOCK, Rufus
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    Segretario
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    British7584610001
    LONGCROFT, Peter Leonard
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    Segretario
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    British32431030003
    MARSHALL, Ian Bruce
    Hungershall Lodge
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    Hungershall Lodge
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    British752600001
    MARSHALL, Ian Bruce
    Hungershall Lodge
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    Hungershall Lodge
    Hungershall Park
    TN4 8ND Tunbridge Wells
    Kent
    British752600001
    MORRISON, Audrey
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    Segretario
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    British44972470001
    ROBINSON, Jill Louise
    81 Old Gansha Road
    BT19 7HA Bangor
    Down
    N Ireland
    Segretario
    81 Old Gansha Road
    BT19 7HA Bangor
    Down
    N Ireland
    British114372460001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Segretario
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    British45988970001
    AIKEN, Neil Gordon
    The Birches 14 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    Amministratore
    The Birches 14 Stradbroke Drive
    IG7 5QX Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish43380390001
    BARKER, Nicholas David
    Benhall Place
    Low Street, Benhall
    IP17 1JF Saxmundham
    Suffolk
    Amministratore
    Benhall Place
    Low Street, Benhall
    IP17 1JF Saxmundham
    Suffolk
    United KingdomBritish41800250004
    BEEVER, David Milton Maxwell
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    Amministratore
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    United KingdomBritish35274610001
    CHARLTON, John Michael
    Dunstone
    5 Broomfield Ride
    KT22 0LR Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Dunstone
    5 Broomfield Ride
    KT22 0LR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritish73081460001
    DEDMAN, John Arnold
    Heather Court
    Broomhall Road
    GU21 4AP Woking
    Surrey
    Amministratore
    Heather Court
    Broomhall Road
    GU21 4AP Woking
    Surrey
    British102358040001
    FOSSE, Finn Erik
    5 Orchard Lane
    SW20 0SE London
    Amministratore
    5 Orchard Lane
    SW20 0SE London
    Norwegian118721520001
    HARDWICK, Michael Robert
    The Laurels 9 Patmore Lane
    Burwood Park
    KT12 5DX Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Laurels 9 Patmore Lane
    Burwood Park
    KT12 5DX Walton On Thames
    Surrey
    British71971030001
    INNES, Michael Ernest Ashley
    Woodlands 4 Winchelsey Rise
    CR2 7BN South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Woodlands 4 Winchelsey Rise
    CR2 7BN South Croydon
    Surrey
    British41782380001
    LAYCOCK, Rufus
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    Amministratore
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    United KingdomBritish7584610001
    LEATHES, Simon William De Mussenden
    19 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Amministratore
    19 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British9808160001
    MYALL, Paul Geoffrey
    10 Latimer Road
    Wimbledon
    SW19 1EP London
    Amministratore
    10 Latimer Road
    Wimbledon
    SW19 1EP London
    New Zealander/British41747120001
    O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas
    1 Windermere Road
    Ealing
    W5 4TJ London
    Amministratore
    1 Windermere Road
    Ealing
    W5 4TJ London
    Irish56976610001
    RANDALL, Colin
    3 Raglan Court
    CR2 6NT South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    3 Raglan Court
    CR2 6NT South Croydon
    Surrey
    British76844920001
    RANDALL, Colin
    3 Raglan Court
    CR2 6NT South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    3 Raglan Court
    CR2 6NT South Croydon
    Surrey
    British76844920001
    READ, Philip David
    35 Elwill Way
    BR3 3AB Beckenham
    Kent
    Amministratore
    35 Elwill Way
    BR3 3AB Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish81624400001
    ROBINSON, Jill Louise
    81 Old Gansha Road
    BT19 7HA Bangor
    Down
    N Ireland
    Amministratore
    81 Old Gansha Road
    BT19 7HA Bangor
    Down
    N Ireland
    Northern IrelandBritish114372460001
    TUGHAN, Frederick David
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Amministratore
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Northern IrelandBritish203412740001
    WHITING, Kevin John
    30 Gloucester Circus
    Greenwich
    SE10 8RY London
    Amministratore
    30 Gloucester Circus
    Greenwich
    SE10 8RY London
    British43709920002
    WOODS, Ronald Ernest
    All Seasons House
    Sterlings Field
    SL6 9PG Cookham Dean
    Berks
    Amministratore
    All Seasons House
    Sterlings Field
    SL6 9PG Cookham Dean
    Berks
    United KingdomBritish149388120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Almira Holdings Ltd
    Rosemary Street
    BT1 1QD Belfast
    20
    Northern Ireland
    06 apr 2016
    Rosemary Street
    BT1 1QD Belfast
    20
    Northern Ireland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleNorthern Ireland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security assignment made between the company formerly known as dresdner kleinwort wasserstein leasing june (1) limited and lombard north central PLC
    Creato il 29 giu 2001
    Consegnato il 10 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All obligations whether actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the assignors to the chargee pursuant to the loan agreement and to this assignment
    Brevi particolari
    All of the right title benefit and interest of the assignor whatsoever present and future in the assigned rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 10 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0