FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02184502 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | All Seasons Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN LEASING JUNE (1) LIMITED | 30 apr 2001 | 30 apr 2001 |
| KLEINWORT BENSON LEASING JUNE (1) LTD. | 22 dic 1995 | 22 dic 1995 |
| S.G. WARBURG & CO. (LEASING) (NUMBER 2) LTD. | 10 mag 1988 | 10 mag 1988 |
| PALLAS LEASING (NUMBER 42) LTD | 28 ott 1987 | 28 ott 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 nov 2017, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 nov 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2017 al 30 nov 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Jill Louise Robinson come amministratore in data 15 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jill Louise Robinson come segretario in data 15 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Ron Woods come segretario in data 09 mar 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG England a All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG in data 09 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Courtlands 8 Plymouth Drive Barnt Green Worcestershire B45 8JB a All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG in data 09 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOODS, Ron | Segretario | Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead All Seasons Berkshire England | 205931680001 | |||||||
| WOODS, Ronald Ernest | Amministratore | Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead All Seasons Berkshire England | United Kingdom | British | 149388120001 | |||||
| AMEY, Michelle | Segretario | 4 Holme Road RM11 3QS Hornchurch Essex | British | 57746950002 | ||||||
| CLIFTON, Roger Cheston | Segretario | 8 Sandy Close GU22 8BQ Woking Surrey | British | 8089410002 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| LAYCOCK, Rufus | Segretario | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | British | 7584610001 | ||||||
| LONGCROFT, Peter Leonard | Segretario | 4 Lakeside Close Reydon IP18 6YA Southwold Suffolk | British | 32431030003 | ||||||
| MARSHALL, Ian Bruce | Segretario | Hungershall Lodge Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 752600001 | ||||||
| MARSHALL, Ian Bruce | Segretario | Hungershall Lodge Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 752600001 | ||||||
| MORRISON, Audrey | Segretario | 20 Bliss Avenue SG17 5SF Shefford Bedfordshire | British | 44972470001 | ||||||
| ROBINSON, Jill Louise | Segretario | 81 Old Gansha Road BT19 7HA Bangor Down N Ireland | British | 114372460001 | ||||||
| YOUNG, Lorraine Elizabeth | Segretario | 3 Vaughan Avenue TN10 4EB Tonbridge Kent | British | 45988970001 | ||||||
| AIKEN, Neil Gordon | Amministratore | The Birches 14 Stradbroke Drive IG7 5QX Chigwell Essex | United Kingdom | British | 43380390001 | |||||
| BARKER, Nicholas David | Amministratore | Benhall Place Low Street, Benhall IP17 1JF Saxmundham Suffolk | United Kingdom | British | 41800250004 | |||||
| BEEVER, David Milton Maxwell | Amministratore | Warren Farm House South Drive GU25 4JS Wentworth Surrey | United Kingdom | British | 35274610001 | |||||
| CHARLTON, John Michael | Amministratore | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||
| DEDMAN, John Arnold | Amministratore | Heather Court Broomhall Road GU21 4AP Woking Surrey | British | 102358040001 | ||||||
| FOSSE, Finn Erik | Amministratore | 5 Orchard Lane SW20 0SE London | Norwegian | 118721520001 | ||||||
| HARDWICK, Michael Robert | Amministratore | The Laurels 9 Patmore Lane Burwood Park KT12 5DX Walton On Thames Surrey | British | 71971030001 | ||||||
| INNES, Michael Ernest Ashley | Amministratore | Woodlands 4 Winchelsey Rise CR2 7BN South Croydon Surrey | British | 41782380001 | ||||||
| LAYCOCK, Rufus | Amministratore | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | United Kingdom | British | 7584610001 | |||||
| LEATHES, Simon William De Mussenden | Amministratore | 19 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 9808160001 | ||||||
| MYALL, Paul Geoffrey | Amministratore | 10 Latimer Road Wimbledon SW19 1EP London | New Zealander/British | 41747120001 | ||||||
| O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas | Amministratore | 1 Windermere Road Ealing W5 4TJ London | Irish | 56976610001 | ||||||
| RANDALL, Colin | Amministratore | 3 Raglan Court CR2 6NT South Croydon Surrey | British | 76844920001 | ||||||
| RANDALL, Colin | Amministratore | 3 Raglan Court CR2 6NT South Croydon Surrey | British | 76844920001 | ||||||
| READ, Philip David | Amministratore | 35 Elwill Way BR3 3AB Beckenham Kent | United Kingdom | British | 81624400001 | |||||
| ROBINSON, Jill Louise | Amministratore | 81 Old Gansha Road BT19 7HA Bangor Down N Ireland | Northern Ireland | British | 114372460001 | |||||
| TUGHAN, Frederick David | Amministratore | Portavo House 176 Warren Road BT21 0PJ Donaghadee Co Down | Northern Ireland | British | 203412740001 | |||||
| WHITING, Kevin John | Amministratore | 30 Gloucester Circus Greenwich SE10 8RY London | British | 43709920002 | ||||||
| WOODS, Ronald Ernest | Amministratore | All Seasons House Sterlings Field SL6 9PG Cookham Dean Berks | United Kingdom | British | 149388120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almira Holdings Ltd | 06 apr 2016 | Rosemary Street BT1 1QD Belfast 20 Northern Ireland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
FITZGEORGE JUNE (1) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment made between the company formerly known as dresdner kleinwort wasserstein leasing june (1) limited and lombard north central PLC | Creato il 29 giu 2001 Consegnato il 10 lug 2001 | In corso | Importo garantito All obligations whether actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the assignors to the chargee pursuant to the loan agreement and to this assignment | |
Brevi particolari All of the right title benefit and interest of the assignor whatsoever present and future in the assigned rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0