HEXEL INTERNATIONAL LIMITED

HEXEL INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEXEL INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02186522
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEXEL INTERNATIONAL LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova HEXEL INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Airedale Mill
    Lawkholme Lane
    BD21 3BB Keighley
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEXEL INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEXAGON LIMITED17 dic 198717 dic 1987
    MATAHARI 150 LIMITED02 nov 198702 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEXEL INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per HEXEL INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 ott 2011

    • Capitale: GBP 0.04
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel capital redemption reserve 12/10/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Sydney Sagar Kershaw il 13 gen 2011

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Sydney Sagar Kershaw il 27 ago 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Sydney Sagar Kershaw il 25 ago 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di HEXEL INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRETTSCHNEIDER, Ulf Stefan
    Shelgate Road
    SW11 1BA London
    35
    Amministratore
    Shelgate Road
    SW11 1BA London
    35
    United KingdomGerman125315710001
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    Airedale Mill
    Lawkholme Lane
    BD21 3BB Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Airedale Mill
    Lawkholme Lane
    BD21 3BB Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish1554150010
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    British1554150009
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    British1554150009
    KITSON, John Edward
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    British102500730001
    LIGGITT, John
    11 Mandeville Road
    HP16 9DS Great Missenden
    Buckinghamshire
    Segretario
    11 Mandeville Road
    HP16 9DS Great Missenden
    Buckinghamshire
    British101533460001
    LISTER, Robert Stephen
    Briery Wood
    Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QQ Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Briery Wood
    Hebers Ghyll Drive
    LS29 9QQ Ilkley
    West Yorkshire
    British161918280001
    DAVIES, Lyn Theodore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    British34304310003
    ELLIS, Stephen Mark
    4 Hilton Mews
    Bramhope
    LS16 9LF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Hilton Mews
    Bramhope
    LS16 9LF Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish53625240002
    ELLIS, Stephen Mark
    1 Mulberry Garth
    Adel
    LS16 8LQ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Mulberry Garth
    Adel
    LS16 8LQ Leeds
    West Yorkshire
    British53625240001
    GOODWIN, Michael John Lynch
    Londesborough Lodge
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8LB South Godstone
    Surrey
    Amministratore
    Londesborough Lodge
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8LB South Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish75546110001
    HEMENS, Harry William
    7 Church Lane
    Moulton
    PE12 6NP Spalding
    Lincolnshire
    Amministratore
    7 Church Lane
    Moulton
    PE12 6NP Spalding
    Lincolnshire
    EnglandBritish7756450001
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Hollies
    Oakworth
    BD22 7HL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish1554150009
    KITSON, John Edward
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Poplar House
    Old Road Dunkeswick
    LS17 9HY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish102500730001
    LIGGITT, John
    11 Mandeville Road
    HP16 9DS Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    11 Mandeville Road
    HP16 9DS Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish101533460001
    MARSH, Robert Drayson
    The Malt House
    Berrick Salome
    OX10 6JN Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Malt House
    Berrick Salome
    OX10 6JN Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish109872320001
    NELMS, Nigel Peter
    Maybury House
    Milton Road
    RG40 1DD Wokingham
    Berks
    Amministratore
    Maybury House
    Milton Road
    RG40 1DD Wokingham
    Berks
    British97335690001
    ROSE, Ian
    35 Hale Pit Road
    Bookham
    KT23 4BS Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    35 Hale Pit Road
    Bookham
    KT23 4BS Leatherhead
    Surrey
    British64926520001
    THOMPSON, David John
    38 Stanley Hill Avenue
    HP7 9BB Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    38 Stanley Hill Avenue
    HP7 9BB Amersham
    Buckinghamshire
    British43465830002
    YEWDALL, Neil Stuart
    31 St Helens Lane
    Adel
    LS16 8BR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    31 St Helens Lane
    Adel
    LS16 8BR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish17046770002
    YEWDALL, Neil Stuart
    9 Long Meadows
    Bramhope
    LS16 9DA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Long Meadows
    Bramhope
    LS16 9DA Leeds
    West Yorkshire
    British17046770001

    HEXEL INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 lug 2006
    Consegnato il 29 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 lug 2006
    Consegnato il 27 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Ian Newett
    Transazioni
    • 27 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 15TH november 2000
    Creato il 15 feb 2001
    Consegnato il 22 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) (the "security trustee") under the facility documents (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 18 ago 1995
    Consegnato il 25 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 20TH july 1995 in favour of h m customs and excise for £30,000
    Brevi particolari
    The sum of £60,000 together with interest held by the bank on an account numbered 15182878 and designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 ago 1995
    Consegnato il 23 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 24 ago 1994
    Consegnato il 01 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 19TH august 1994 in favour of hm customs & excise for £15,000
    Brevi particolari
    The sum of £30,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 15182878 & earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 30 mag 1990
    Consegnato il 14 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from hexel group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    (Including trade fixtues). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mag 1990
    Consegnato il 08 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 08 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0