PROCIS SOFTWARE LIMITED

PROCIS SOFTWARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROCIS SOFTWARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02186524
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Severn Trent Centre
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIFTMAZE LIMITED02 nov 198702 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 1003 of the companies act 2006 28/09/2018
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 19 ott 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 28/09/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Richard Eadie come amministratore in data 29 mar 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark James Dovey come amministratore in data 14 dic 2017

    1 pagineTM01

    Notifica di Severn Trent Systems Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2016

    Stato del capitale al 25 lug 2016

    • Capitale: GBP 4,250,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2015

    Stato del capitale al 20 ago 2015

    • Capitale: GBP 4,250,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Nomina di Aline Anne Campbell come segretario in data 04 set 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Matthew Armitage come segretario in data 03 set 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 16 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 set 2014

    Stato del capitale al 18 set 2014

    • Capitale: GBP 4,250,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMPBELL, Aline Anne
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    Segretario
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    191783530001
    EADIE, Richard
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector208711590001
    MCPHEELY, Robert Craig
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant104273610001
    ARMITAGE, Matthew
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Segretario
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    157947330001
    BRIERLEY, Richard Paul
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Segretario
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    146002380001
    CHETTLE, David
    Arden
    4 Leire Lane
    LE17 5JP Dunton Bassett
    Leicestershire
    Segretario
    Arden
    4 Leire Lane
    LE17 5JP Dunton Bassett
    Leicestershire
    British39794800007
    DAVEY, Jonathan Roger Metherall
    Well House
    Yarningale Lane, Yarningale Common
    CV35 8HW Claverdon
    Warwickshire
    Segretario
    Well House
    Yarningale Lane, Yarningale Common
    CV35 8HW Claverdon
    Warwickshire
    British182854890001
    ELPHICK, Michael Edward
    Bryn Y Coed
    Crwbin
    SA17 5DR Kidwelly
    Dyfed
    Segretario
    Bryn Y Coed
    Crwbin
    SA17 5DR Kidwelly
    Dyfed
    British3917550001
    PORRITT, Kerry Anne Abigail
    Brushwood House
    22 Clarence Road
    WR14 3EH Great Malvern
    Worcestershire
    Segretario
    Brushwood House
    22 Clarence Road
    WR14 3EH Great Malvern
    Worcestershire
    BritishChartered Secretary166987180001
    WILKINSON, Caroline Lesley
    55 Inglewood Grove
    B74 3LN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    55 Inglewood Grove
    B74 3LN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British68331390001
    BROWN, Alan Keith
    Virginia House
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Virginia House
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    BritishComputer Consultant24578540003
    BROWN, Jeffrey Andrew
    2610 Kings Forest Drive
    Kingwood 77339
    Texas Usa
    Amministratore
    2610 Kings Forest Drive
    Kingwood 77339
    Texas Usa
    AmericanDirector65731470001
    CLARK, Ian Peter
    5 Pentland Road
    LE65 1BA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Pentland Road
    LE65 1BA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishDirector33964220002
    COATES, John Desmond
    50 Courtbrook
    GL7 4BE Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    50 Courtbrook
    GL7 4BE Fairford
    Gloucestershire
    BritishMarketing+Business Development29129780001
    DOVEY, Mark James, Mr.
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Tax Manager166254070001
    FRANEY, John
    11 Larch Close
    CV37 6XJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    11 Larch Close
    CV37 6XJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector56000020001
    GALE, David John
    3 Habberley Croft
    B91 3YR Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Habberley Croft
    B91 3YR Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director107152670001
    LILY, Michael
    The Thatched House 16 Tavern Lane
    Shottery
    CV37 9HE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    The Thatched House 16 Tavern Lane
    Shottery
    CV37 9HE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector35109650002
    LLOYD, Robert Alexander
    1 Butt Lane
    Blackfordby
    DE11 8BG Swadlincote
    Derbyshire
    Amministratore
    1 Butt Lane
    Blackfordby
    DE11 8BG Swadlincote
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director104326720001
    LUCAS, Michael Kevin
    Beechfield House Beechfield Lane
    Frilsham Hermitage
    RG16 9XD Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Beechfield House Beechfield Lane
    Frilsham Hermitage
    RG16 9XD Newbury
    Berkshire
    BritishChartered Accountant38443310001
    PARKINSON, Robert Walsh, Dr
    Fieldways Bennetts Farm
    Whitewater Road Leighterton
    GL8 8UJ Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Fieldways Bennetts Farm
    Whitewater Road Leighterton
    GL8 8UJ Tetbury
    Gloucestershire
    BritishBusiness Advisor50778500001
    PETERS, Colin Leslie
    Oakbourne House
    Bucklebury Common
    RG7 6QB Reading
    Berks
    Amministratore
    Oakbourne House
    Bucklebury Common
    RG7 6QB Reading
    Berks
    BritishChartered Accountant15445330001
    PICKEN, Ruth
    73 Brook Lane
    Walsall Wood
    WS9 9NA Walsall
    Amministratore
    73 Brook Lane
    Walsall Wood
    WS9 9NA Walsall
    United KingdomBritishChartered Accountant89937800002
    PIPER, Richard Gary
    5 Lomax Close
    WS13 7EY Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Lomax Close
    WS13 7EY Lichfield
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant98938620001
    PORRITT, Kerry Anne Abigail
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Secretary166987180001
    ROWE, John
    14 Lyndhurst Road
    Keynsham
    BS18 1RQ Bristol
    Avon
    Amministratore
    14 Lyndhurst Road
    Keynsham
    BS18 1RQ Bristol
    Avon
    BritishComputer Consultant24578550001
    SENIOR, Paul Michael
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director120413260001
    TYLER, Gerard Peter
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant40481670003

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROCIS SOFTWARE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Severn Trent Systems Limited
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    06 apr 2016
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House (England And Wales)
    Numero di registrazione2394552
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PROCIS SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Declaration of trust and agreement
    Creato il 03 lug 1997
    Consegnato il 19 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantees dated 29TH january 1997
    Brevi particolari
    All monies resulting from the enforcement of a deed of assignment of intelectual property rights and floating charge dated 9 december 1994 between the company and the chargee.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC, Alan Brown, Michael Lucas, Colin Peters, Robert Parkinson, Desmond Coatesand Pammi Panesar
    Transazioni
    • 19 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Declaration of trust and agreement
    Creato il 27 gen 1997
    Consegnato il 06 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to 3I group PLC pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997, to alan brown pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997, to michael lucas pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997 and to colin peters pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997
    Brevi particolari
    All monies resulting from the enforcement of a deed of assignment of intellectual property rights and floating charge dated 9TH december 1994 and made between the company and 3I group PLC.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC, Alan Brown, Michael Lucas and Colin Peters
    Transazioni
    • 06 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 1994
    Consegnato il 13 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments and investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Creato il 09 dic 1994
    Consegnato il 13 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All copyright, know-how, trade marks, trade names and service marks etc. and a floating charge over all other undertaking property and assets of the company (including uncalled capital). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 dic 1991
    Consegnato il 20 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 feb 1990
    Consegnato il 01 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from and/or procis limited the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0