PROCIS SOFTWARE LIMITED
Panoramica
Nome della società | PROCIS SOFTWARE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02186524 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PROCIS SOFTWARE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PROCIS SOFTWARE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Severn Trent Centre 2 St John's Street CV1 2LZ Coventry |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PROCIS SOFTWARE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LIFTMAZE LIMITED | 02 nov 1987 | 02 nov 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PROCIS SOFTWARE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per PROCIS SOFTWARE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 19 ott 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Richard Eadie come amministratore in data 29 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark James Dovey come amministratore in data 14 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Notifica di Severn Trent Systems Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Aline Anne Campbell come segretario in data 04 set 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Armitage come segretario in data 03 set 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PROCIS SOFTWARE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL, Aline Anne | Segretario | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre | 191783530001 | |||||||
EADIE, Richard | Amministratore | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 208711590001 | ||||
MCPHEELY, Robert Craig | Amministratore | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | England | British | Accountant | 104273610001 | ||||
ARMITAGE, Matthew | Segretario | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | 157947330001 | |||||||
BRIERLEY, Richard Paul | Segretario | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | 146002380001 | |||||||
CHETTLE, David | Segretario | Arden 4 Leire Lane LE17 5JP Dunton Bassett Leicestershire | British | 39794800007 | ||||||
DAVEY, Jonathan Roger Metherall | Segretario | Well House Yarningale Lane, Yarningale Common CV35 8HW Claverdon Warwickshire | British | 182854890001 | ||||||
ELPHICK, Michael Edward | Segretario | Bryn Y Coed Crwbin SA17 5DR Kidwelly Dyfed | British | 3917550001 | ||||||
PORRITT, Kerry Anne Abigail | Segretario | Brushwood House 22 Clarence Road WR14 3EH Great Malvern Worcestershire | British | Chartered Secretary | 166987180001 | |||||
WILKINSON, Caroline Lesley | Segretario | 55 Inglewood Grove B74 3LN Sutton Coldfield West Midlands | British | 68331390001 | ||||||
BROWN, Alan Keith | Amministratore | Virginia House Duntisbourne Abbotts GL7 7JW Cirencester Gloucestershire | British | Computer Consultant | 24578540003 | |||||
BROWN, Jeffrey Andrew | Amministratore | 2610 Kings Forest Drive Kingwood 77339 Texas Usa | American | Director | 65731470001 | |||||
CLARK, Ian Peter | Amministratore | 5 Pentland Road LE65 1BA Ashby De La Zouch Leicestershire | British | Director | 33964220002 | |||||
COATES, John Desmond | Amministratore | 50 Courtbrook GL7 4BE Fairford Gloucestershire | British | Marketing+Business Development | 29129780001 | |||||
DOVEY, Mark James, Mr. | Amministratore | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | England | British | Group Tax Manager | 166254070001 | ||||
FRANEY, John | Amministratore | 11 Larch Close CV37 6XJ Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Director | 56000020001 | |||||
GALE, David John | Amministratore | 3 Habberley Croft B91 3YR Solihull West Midlands | British | Company Director | 107152670001 | |||||
LILY, Michael | Amministratore | The Thatched House 16 Tavern Lane Shottery CV37 9HE Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Director | 35109650002 | |||||
LLOYD, Robert Alexander | Amministratore | 1 Butt Lane Blackfordby DE11 8BG Swadlincote Derbyshire | England | British | Company Director | 104326720001 | ||||
LUCAS, Michael Kevin | Amministratore | Beechfield House Beechfield Lane Frilsham Hermitage RG16 9XD Newbury Berkshire | British | Chartered Accountant | 38443310001 | |||||
PARKINSON, Robert Walsh, Dr | Amministratore | Fieldways Bennetts Farm Whitewater Road Leighterton GL8 8UJ Tetbury Gloucestershire | British | Business Advisor | 50778500001 | |||||
PETERS, Colin Leslie | Amministratore | Oakbourne House Bucklebury Common RG7 6QB Reading Berks | British | Chartered Accountant | 15445330001 | |||||
PICKEN, Ruth | Amministratore | 73 Brook Lane Walsall Wood WS9 9NA Walsall | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 89937800002 | ||||
PIPER, Richard Gary | Amministratore | 5 Lomax Close WS13 7EY Lichfield Staffordshire | British | Chartered Accountant | 98938620001 | |||||
PORRITT, Kerry Anne Abigail | Amministratore | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | England | British | Chartered Secretary | 166987180001 | ||||
ROWE, John | Amministratore | 14 Lyndhurst Road Keynsham BS18 1RQ Bristol Avon | British | Computer Consultant | 24578550001 | |||||
SENIOR, Paul Michael | Amministratore | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 120413260001 | ||||
TYLER, Gerard Peter | Amministratore | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 40481670003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PROCIS SOFTWARE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severn Trent Systems Limited | 06 apr 2016 | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PROCIS SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Declaration of trust and agreement | Creato il 03 lug 1997 Consegnato il 19 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantees dated 29TH january 1997 | |
Brevi particolari All monies resulting from the enforcement of a deed of assignment of intelectual property rights and floating charge dated 9 december 1994 between the company and the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Declaration of trust and agreement | Creato il 27 gen 1997 Consegnato il 06 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to 3I group PLC pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997, to alan brown pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997, to michael lucas pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997 and to colin peters pursuant to a guarantee agreement dated 29TH january 1997 | |
Brevi particolari All monies resulting from the enforcement of a deed of assignment of intellectual property rights and floating charge dated 9TH december 1994 and made between the company and 3I group PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 dic 1994 Consegnato il 13 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments and investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge | Creato il 09 dic 1994 Consegnato il 13 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All copyright, know-how, trade marks, trade names and service marks etc. and a floating charge over all other undertaking property and assets of the company (including uncalled capital). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 dic 1991 Consegnato il 20 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 22 feb 1990 Consegnato il 01 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from and/or procis limited the company to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0