STROBE 3

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTROBE 3
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02188184
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STROBE 3?

    • (7487) /

    Dove si trova STROBE 3?

    Indirizzo della sede legale
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STROBE 3?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LUMINAR LEISURE LIMITED16 lug 200116 lug 2001
    NORTHERN LEISURE LIMITED30 nov 199330 nov 1993
    WHITEGATE LEISURE PLC15 dic 198715 dic 1987
    HARVESTING PUBLIC LIMITED COMPANY03 nov 198703 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di STROBE 3?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STROBE 3?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STROBE 3?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 giu 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 dic 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 giu 2013

    15 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY in data 22 lug 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 giu 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 dic 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 giu 2012

    5 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2011

    18 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2010

    16 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    28 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Euro House 1394 High Road London N20 9YZ in data 12 mar 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 28 feb 2008

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2009 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di STROBE 3?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARDEN, Christian
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    Amministratore
    94 Portland Place
    W1B 1NZ London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish62937340001
    BARRETT, David William
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    Amministratore
    4 Furzey Road
    Upton
    BH16 5RW Poole
    Dorset
    EnglandBritish2264460001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Segretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Segretario
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    British71842080001
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Segretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Segretario
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    ARNOLD, Michael John
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    British48184650002
    AUST, Jonathan Neale
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    Amministratore
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    EnglandBritish160178570001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Amministratore
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BEIGHTON, Nicholas Timothy
    Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    8
    Hertfordshire
    Amministratore
    Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    8
    Hertfordshire
    UkBritish107221780003
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Amministratore
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    GILLY, Edward Pierre
    Suite 15 Edgecliff Mews
    201 New South Head Road Edgecliff
    Sydney 2027
    Australia
    Amministratore
    Suite 15 Edgecliff Mews
    201 New South Head Road Edgecliff
    Sydney 2027
    Australia
    Australian68452000001
    HANSON, James Donald
    18 Thurloe Place
    SW7 2SP London
    Amministratore
    18 Thurloe Place
    SW7 2SP London
    British45201690007
    LOADES, Stephen
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bank Cottage
    25 Drayton Park
    NN11 5TB Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish77619750001
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001
    MANSER, Ronald Douglas
    34 Warren Road
    Double Bay
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2028
    Australia
    Amministratore
    34 Warren Road
    Double Bay
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2028
    Australia
    Australian68452010001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MARKS, Peter Jack
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Redhouse
    54 High Street
    NN13 7DS Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish77895710001
    MARSHALL, Anthony
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5 Brickhill Manor Court
    Watling Street, Little Brickhill
    MK17 9LN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish155979460001
    MASSEY, Graham
    134 Newton Drive
    FY3 8JB Blackpool
    Amministratore
    134 Newton Drive
    FY3 8JB Blackpool
    British34414530001
    MCDONALD, Robert James
    Darnford Lane
    WS14 9JQ Lichfield
    Whittington Hill House
    Staffordshire
    Amministratore
    Darnford Lane
    WS14 9JQ Lichfield
    Whittington Hill House
    Staffordshire
    EnglandBritish157701860001
    MCENHILL, Peter Raymond
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    British65346840001
    MCIVOR, Andrew
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    6 Castle View Lane
    Murieston
    EH54 9HN Livingston
    West Lothian
    British61144120003
    MCLOUGHLIN, Brendan Michael
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    Amministratore
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    United KingdomBritish40530320004
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    OPPENHEIM, James Nicholas
    33 King Street
    SW1Y 6RJ London
    Amministratore
    33 King Street
    SW1Y 6RJ London
    United KingdomBritish26933450003
    PATTISSON, John Harmer
    1c Elm Place
    SW7 3QH London
    Amministratore
    1c Elm Place
    SW7 3QH London
    British23743570001
    PRESTON, Clive Henry
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Amministratore
    37 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    EnglandBritish1973870004

    STROBE 3 ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed creating a floating charge
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 15 ago 2007
    Consegnato il 30 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditor
    Transazioni
    • 30 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 09 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future monies debts and liabilities due or to become due from any chargor to the chargee as security trustee (the "security trustee") as security trustee for the benefit of the secured creditors (as defined) in relation to any of the creditor finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 16 nov 1999
    Consegnato il 22 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the beneficiaries) under or pursuant to the finance documents
    Brevi particolari
    By way of first floating charge the undertaking and assets present & future.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ago 1998
    Consegnato il 18 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (as defined therein) to the chargee under or in respect of (a) a loan agreement dated 9 september 1996 (as amended by supplemental agreements dated 29 august 1997 and 12 august 1998 and as amended from time to time); (b) the debenture; (c) any other monies incurred by the chargee under this security or any other security; (d) any other monies owing to the chargee on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ago 1998
    Consegnato il 18 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (as defined therein) to the chargee under or in respect of (a) a loan agreement dated 9 september 1996 (as amended by supplemental agreements dated 29 august 1997 and 12 august 1998 and as amended from time to time); (b) the debenture; (c) any other monies incurred by the chargee under this security or any other security; (d) any other monies owing to the chargee on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all the interest in land and fixtures;first fixed charge over plant and machinery uncalled capital debts & goodwill; first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ago 1998
    Consegnato il 18 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (as defined therein) to the chargee under or in respect of (a) a loan agreement dated 9 september 1996 (as amended by supplemental agreements dated 29 august 1997 and 12 august 1998 and as amended from time to time); (b) the debenture; (c) any other monies incurred by the chargee under this security or any other security; (d) any other monies owing to the chargee on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all the interest in land and fixtures; first fixed charge over plant and machinery uncalled capital debts & goodwill; first floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A supplemental deed
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 15 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement, the debenture and the guarantee (all as defined)
    Brevi particolari
    Are charged to the bank in accordance with clause 2 of the debenture as amended by the supplemental deed. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A supplemental deed
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 19 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement, the debenture and the guarantee (all as defined)
    Brevi particolari
    Are charged to the bank in accordance with clause 2 of the debenture as amended by the supplemental deed. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A supplemental deed
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 15 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement (as defined), the debenture (as defined) and the guarantee (as defined)
    Brevi particolari
    All of the property assets and undertaking of the company are charged to the bank in accordance with clause 2 of the debenture as amended by the supplemental deed.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 set 1996
    Consegnato il 18 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any liability of either the chargor or northern leisure inc. PLC to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 9TH september 1996 the debenture and a guarantee dated 9TH september 1996
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 set 1996
    Consegnato il 18 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any liability of either the chargor or northern leisure inc. PLC to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 9TH september 1996 the debenture and a guarantee dated 9TH september 1996
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 set 1996
    Consegnato il 18 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any liability of either the chargor or northern leisure inc. PLC to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 9TH september 1996 the debenture and a guarantee dated 9TH september 1996
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture`
    Creato il 19 apr 1995
    Consegnato il 27 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the royal bank of soctland PLC- as agent and trustee for itself and for each of the banks, as defined ) under or pursuant to the terms of the revolving credit facility agreement dated 13TH march 1995 and /or this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,,National Westminster Bank PLC. the Governor and Company of Thebank of Scotland ,Collectively " the Banks"
    Transazioni
    • 27 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 08 lug 1994
    Consegnato il 21 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee for the stockholders (in this capacity the "trustee") under the terms of or in respect of the trust deed, the original stock, any further stock, this composite debenture and the composite guarantee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 21 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 06 nov 1992
    Consegnato il 18 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in respect of a revolving credit facility agreement,a composite debenture and a composite guarantee all dated 24TH december 1991 or any other security as defined in this assignment
    Brevi particolari
    All the right,title,benefit and interest in the guarantee dated 6TH november 1992,a share purchase agreement dated 6TH october 1992 and an inter company loan (see doc ref M522C for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 24 dic 1991
    Consegnato il 07 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the security documents as defined
    Brevi particolari
    See doc ref M566C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STROBE 3 ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 mar 2010Inizio dell'amministrazione
    01 lug 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul John Clark
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    DataTipo
    01 lug 2011Inizio della liquidazione
    26 feb 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul John Clark
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0