BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED

BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02189208
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMMUNITY LEISURE LIMITED24 ago 198824 ago 1988
    TRENDLAST INVESTMENTS LIMITED05 nov 198705 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zane Cedomir Mersich il 11 gen 2022

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zane Cedomir Mersich il 22 set 2020

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB in data 13 lug 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England a Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB in data 16 mar 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Neil Paramore come amministratore in data 23 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Paramore come segretario in data 23 gen 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew Mark Glennon come segretario in data 23 gen 2020

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew Mark Glennon come amministratore in data 23 gen 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 11 giu 2016

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Segretario
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266813330001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Amministratore
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Indsutrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Amministratore
    South Road
    Bridgend Indsutrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    HAWKINS, Christopher Lawrence
    Longmeadow Hollywood Lane
    West Kingsdown
    TN15 6JG Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Longmeadow Hollywood Lane
    West Kingsdown
    TN15 6JG Sevenoaks
    Kent
    British4786140001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Segretario
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209531210001
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965100002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Segretario
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BENSTED, Terence Charles
    80 Bayham Road
    TN13 3XA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    80 Bayham Road
    TN13 3XA Sevenoaks
    Kent
    British10397520002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    HAWKINS, Christopher Lawrence
    Longmeadow Hollywood Lane
    West Kingsdown
    TN15 6JG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Longmeadow Hollywood Lane
    West Kingsdown
    TN15 6JG Sevenoaks
    Kent
    British4786140001
    HUNT, Alan Michael
    60 Corner Green
    SE3 9JJ Blackheath
    Amministratore
    60 Corner Green
    SE3 9JJ Blackheath
    United KingdomBritish152619070001
    MCDONALD, Peter Stuart
    Limes Farmhouse
    Upper Lambourn
    RG17 8RG Hungerford
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Limes Farmhouse
    Upper Lambourn
    RG17 8RG Hungerford
    Berkshire
    England
    British77781180003
    NASH, Hugh
    26 Bowen Craig
    KA30 8TB Largs
    Ayrshire
    Amministratore
    26 Bowen Craig
    KA30 8TB Largs
    Ayrshire
    United KingdomBritish67083290004
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Amministratore
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001
    REILLY, Francis Martin
    38 Sandford Road
    ME10 1PP Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    38 Sandford Road
    ME10 1PP Sittingbourne
    Kent
    Irish68538080001
    SMITH, David Henry
    9 Seagry Road
    Wanstead
    E11 2NG London
    Amministratore
    9 Seagry Road
    Wanstead
    E11 2NG London
    British10378300001
    SMITH, Graham George
    The Old Rectory Provender Lane
    Norton
    ME13 0SU Faversham
    Kent
    Amministratore
    The Old Rectory Provender Lane
    Norton
    ME13 0SU Faversham
    Kent
    British10235440001
    VALLANCE, Ronald James
    25 Penton Court
    Jamnagar Close
    TW18 2JU Staines
    Middlesex
    Amministratore
    25 Penton Court
    Jamnagar Close
    TW18 2JU Staines
    Middlesex
    British52277700002

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06 apr 2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05382157
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BLACKHEATH LEISURE (CAROUSEL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to schedule to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 08 feb 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 21 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any facility letter (as defined)
    Brevi particolari
    L/Hold land comprising ground floor,219 portobello rd,london W.11 and all rents under any leases or tenancies,all benefits in respect of insurances and all claims/returns of premiums,all contracts or policies of insurance thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 21 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1998
    Consegnato il 25 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    229 walworth road london london borough of southwark together with all rental monies and benefit of all insurances.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1998
    Consegnato il 25 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    219 portobello road london 11 london borough of kensington & chelsea together wityh all rental monies and benefits of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 set 1997
    Consegnato il 26 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property 38, denmark hill camberwell t/n TGL9989, 58 hare street t/n LN185061 and 62 high street stoke newington t/n MX328147 for details of further properties charges please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 26 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 apr 1997
    Consegnato il 22 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The machines outlined in the 48 pages attached to the form 395 eg baby bar x office no 3274 serial no 100067 purchased status 22-03-1990 in use,sevens above 3295 serial no 5628 purchased status 02-03-1990 in use,big 7 office no 3628 serial no 44376 purchased status 30-07-1990 in use. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 30 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Baby bar x ser/no 100067 sevens above ser/no 5628 big 7 ser/no 44376 baby bar x ser/no 101149 super bar x ser/no 101264 and 101532 and all the other chattels as listed on the listing attached to the form 395 (46 pages). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 giu 1996
    Consegnato il 24 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various chattels please see 43 pages attached to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1996
    Consegnato il 29 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Basement, ground, first and second floors k/a 213 whitechapel road L.B. of tower hamlets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mag 1996
    Consegnato il 13 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    173 upper fore st,edmonton,london borough of enfield.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor shop and basement beneath it at 53 junction road, islington l/b of islington t/no: ngl 734605.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1996
    Consegnato il 19 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lock-up shop at 168 clapton common london borough of hackney. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 feb 1996
    Consegnato il 20 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The machines described in the schedule attached to form 395 please refer to form and schedule for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1996
    Consegnato il 23 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    173 upper fore street edmonton london borough of enfield.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 23 nov 1995
    Consegnato il 29 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various chattels detailed on the 46 page schedule attached to form 395 including :- machines named "bar x" "seven heaven" "baby bar x" "sevens above" etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 lug 1995
    Consegnato il 07 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The listings consisting of fifty pages which are attached to the form 395AND list machine names I.E. bar x, seven heaven, baby bar 7, sevens above, big 7 etc and the serial numbers. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 mar 1995
    Consegnato il 27 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    67 kingsland high street, london borough of hackney,.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mar 1995
    Consegnato il 30 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    314-315 (unit no 96) lower ground floor, elelphant & castle shopping centre, elephant & castle l/b of southwark.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 22 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    67 kingsland high street, london, l/b of hackney t/no: LN11991.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1995
    Consegnato il 22 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    58/58A high road, ilford, essex l/b of redbridge t/no: egl 286868.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 dic 1994
    Consegnato il 09 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    83 high street, eltham, l/b of greenwich.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 nov 1994
    Consegnato il 10 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Silver gghost machine 0004 ser: no: 61145. bar x 0047 serial no; 111298 and various other chattels as listed on schedule to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 set 1994
    Consegnato il 06 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    168 clapton common, l/b of hackney t/n 322872.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0