BILASH FOODS LIMITED

BILASH FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBILASH FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02193302
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BILASH FOODS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BILASH FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BILASH FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    G.T.D. LIMITED13 nov 198713 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di BILASH FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BILASH FOODS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BILASH FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 06/05/2015
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2015

    Stato del capitale al 10 feb 2015

    • Capitale: GBP 166
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Stephen Jay Smith come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Denise Menikheim Faltischek come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Irwin David Simon come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Burnett come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2014

    Stato del capitale al 08 gen 2014

    • Capitale: GBP 166
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BILASH FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUDSON, Jeremy Stuart
    West End Avenue
    HG2 9BX Harrogate
    83
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    West End Avenue
    HG2 9BX Harrogate
    83
    North Yorkshire
    United Kingdom
    BritishFinance Director90292510003
    FALTISCHEK, Denise Menikheim
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    United StatesAmericanExecutive Vice President And General Counsel178917830001
    HUDSON, Jeremy Stuart
    West End Avenue
    HG2 9BX Harrogate
    83
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    West End Avenue
    HG2 9BX Harrogate
    83
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director90292510004
    SIMON, Irwin David
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    United StatesAmericanCeo170074710001
    SMITH, Stephen Jay
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Acorn Business Park
    Killingbeck Drive York Road
    LS14 6UF Leeds
    West Yorkshire
    UsaUsChief Financial Officer185490610001
    ALI, Mokbul
    436 Thorney Leys
    OX28 5PJ Witney
    Oxfordshire
    Segretario
    436 Thorney Leys
    OX28 5PJ Witney
    Oxfordshire
    British84872620001
    BARCO, Colin Anthony John
    5 Swinbrook Road
    OX18 1DU Carterton
    Oxfordshire
    Segretario
    5 Swinbrook Road
    OX18 1DU Carterton
    Oxfordshire
    TanzanianChartered Accountant63748020002
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    Segretario
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    British41820960003
    NASH, Christopher
    8 Oast Court
    Yalding
    ME18 6JY Maidstone
    Kent
    Segretario
    8 Oast Court
    Yalding
    ME18 6JY Maidstone
    Kent
    British50457750001
    THOMAS, Lynda
    Paddock House Lancot Lane
    Standlake
    OX8 7QJ Witney
    Oxfordshire
    Segretario
    Paddock House Lancot Lane
    Standlake
    OX8 7QJ Witney
    Oxfordshire
    BritishSecretary27078960002
    ALI, Mokbul
    436 Thorney Leys
    OX28 5PJ Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    436 Thorney Leys
    OX28 5PJ Witney
    Oxfordshire
    BritishFood Manufacturer84872620001
    BURNETT, Robert
    44 Woodlands Avenue
    Cults
    AB15 9DE Aberdeen
    Amministratore
    44 Woodlands Avenue
    Cults
    AB15 9DE Aberdeen
    ScotlandBritishCeo86190250002
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Red Roke 137 Epsom Road
    Merrow
    GU1 2PP Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director41820960003
    DODD, Russell Blandy
    3 Abingdon Road
    Standlake
    OX8 7QH Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    3 Abingdon Road
    Standlake
    OX8 7QH Witney
    Oxfordshire
    BritishFood Broker11468440002
    FREEDMAN, Cyril Winston
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    BritishExecutive Chairman1631420001
    MILLS, Michael John
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director34628600001
    THOMAS, Lynda
    Paddock House Lancot Lane
    Standlake
    OX8 7QJ Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    Paddock House Lancot Lane
    Standlake
    OX8 7QJ Witney
    Oxfordshire
    BritishSecretary27078960002
    THOMAS, Paul Bassett
    Adbury Pines
    Adbury Holt
    RG20 9BW Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Adbury Pines
    Adbury Holt
    RG20 9BW Newbury
    Berkshire
    BritishFood Manufacturer70308370001

    BILASH FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 ago 1995
    Consegnato il 12 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on the equipemtn as specified in the schedule to form 395 fixed charge on the land and buildings at units 5 and 6 west oxfordshire industrial park brize norton oxfordshire OX18 3YJ and a floating charge on the undertaking of the company and all it's other property and assets both present and future including it's uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Development Commission
    Transazioni
    • 12 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 30 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all square foods LTD. To the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 mag 1989
    Consegnato il 06 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H units 5 & 6 west oxfordshire industrial park brize norton road carterton oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 giu 1988
    Consegnato il 06 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0