BILASH FOODS LIMITED
Panoramica
Nome della società | BILASH FOODS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02193302 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BILASH FOODS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BILASH FOODS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 4 Acorn Business Park Killingbeck Drive York Road LS14 6UF Leeds West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BILASH FOODS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
G.T.D. LIMITED | 13 nov 1987 | 13 nov 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BILASH FOODS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BILASH FOODS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per BILASH FOODS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 11 mag 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jay Smith come amministratore in data 26 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Denise Menikheim Faltischek come amministratore in data 26 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Irwin David Simon come amministratore in data 26 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Burnett come amministratore in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile | 3 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BILASH FOODS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDSON, Jeremy Stuart | Segretario | West End Avenue HG2 9BX Harrogate 83 North Yorkshire United Kingdom | British | Finance Director | 90292510003 | |||||
FALTISCHEK, Denise Menikheim | Amministratore | 4 Acorn Business Park Killingbeck Drive York Road LS14 6UF Leeds West Yorkshire | United States | American | Executive Vice President And General Counsel | 178917830001 | ||||
HUDSON, Jeremy Stuart | Amministratore | West End Avenue HG2 9BX Harrogate 83 North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 90292510004 | ||||
SIMON, Irwin David | Amministratore | 4 Acorn Business Park Killingbeck Drive York Road LS14 6UF Leeds West Yorkshire | United States | American | Ceo | 170074710001 | ||||
SMITH, Stephen Jay | Amministratore | 4 Acorn Business Park Killingbeck Drive York Road LS14 6UF Leeds West Yorkshire | Usa | Us | Chief Financial Officer | 185490610001 | ||||
ALI, Mokbul | Segretario | 436 Thorney Leys OX28 5PJ Witney Oxfordshire | British | 84872620001 | ||||||
BARCO, Colin Anthony John | Segretario | 5 Swinbrook Road OX18 1DU Carterton Oxfordshire | Tanzanian | Chartered Accountant | 63748020002 | |||||
CAWLEY, Hugh Charles Laurence | Segretario | Red Roke 137 Epsom Road Merrow GU1 2PP Guildford Surrey | British | 41820960003 | ||||||
NASH, Christopher | Segretario | 8 Oast Court Yalding ME18 6JY Maidstone Kent | British | 50457750001 | ||||||
THOMAS, Lynda | Segretario | Paddock House Lancot Lane Standlake OX8 7QJ Witney Oxfordshire | British | Secretary | 27078960002 | |||||
ALI, Mokbul | Amministratore | 436 Thorney Leys OX28 5PJ Witney Oxfordshire | British | Food Manufacturer | 84872620001 | |||||
BURNETT, Robert | Amministratore | 44 Woodlands Avenue Cults AB15 9DE Aberdeen | Scotland | British | Ceo | 86190250002 | ||||
CAWLEY, Hugh Charles Laurence | Amministratore | Red Roke 137 Epsom Road Merrow GU1 2PP Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 41820960003 | ||||
DODD, Russell Blandy | Amministratore | 3 Abingdon Road Standlake OX8 7QH Witney Oxfordshire | British | Food Broker | 11468440002 | |||||
FREEDMAN, Cyril Winston | Amministratore | Golden Mead Mead Road BR7 6AD Chislehurst Kent | British | Executive Chairman | 1631420001 | |||||
MILLS, Michael John | Amministratore | Maple Heath Parsonage Lane Farnham Common SL2 3NZ Slough Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 34628600001 | ||||
THOMAS, Lynda | Amministratore | Paddock House Lancot Lane Standlake OX8 7QJ Witney Oxfordshire | British | Secretary | 27078960002 | |||||
THOMAS, Paul Bassett | Amministratore | Adbury Pines Adbury Holt RG20 9BW Newbury Berkshire | British | Food Manufacturer | 70308370001 |
BILASH FOODS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creato il 25 mar 1999 Consegnato il 08 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 ago 1995 Consegnato il 12 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on the equipemtn as specified in the schedule to form 395 fixed charge on the land and buildings at units 5 and 6 west oxfordshire industrial park brize norton oxfordshire OX18 3YJ and a floating charge on the undertaking of the company and all it's other property and assets both present and future including it's uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 25 gen 1995 Consegnato il 30 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all square foods LTD. To the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 22 mag 1989 Consegnato il 06 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H units 5 & 6 west oxfordshire industrial park brize norton road carterton oxfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 01 giu 1988 Consegnato il 06 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0