RMAC 1999-NS2

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRMAC 1999-NS2
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02195220
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RMAC 1999-NS2?

    • (6523) /

    Dove si trova RMAC 1999-NS2?

    Indirizzo della sede legale
    5 Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RMAC 1999-NS2?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RMAC 1999-NS2 LIMITED24 set 200924 set 2009
    RMAC 1999-NS2 PLC19 mag 199919 mag 1999
    THE MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORATION LIMITED26 gen 198826 gen 1988
    PROBEFINAL LIMITED17 nov 198717 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di RMAC 1999-NS2?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per RMAC 1999-NS2?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di Jefrey Lundgren come amministratore

    1 pagineTM01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato

    1 pagineCERT3

    Assenso alla riregistrazione

    1 pagineFOA-RR

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    13 pagineMAR

    Riregistrazione da società a responsabilità limitata privata a società a responsabilità illimitata privata

    2 pagineRR05

    Cessazione della carica di Eileen Mcmillan come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine403a

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    13 pagineMAR

    legacy

    1 pagine53

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    legacy

    2 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    auditors

    Risoluzione di esenzione dalla nomina degli auditor

    RES03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di RMAC 1999-NS2?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SIMPSON, Phillip Bertram
    16 Gatscombe Crescent
    Hanover Park
    SL5 7HA Ascot
    Segretario
    16 Gatscombe Crescent
    Hanover Park
    SL5 7HA Ascot
    British54705580002
    BLIGHT, Godfrey
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    Amministratore
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United KingdomBritish135102120001
    COX, Kenneth Geoffrey
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    Segretario
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    British45253390001
    EDMONDS, Karen Britt
    Badgers Barn
    Farthings Paddock
    BA7 7QA Alford
    Somerset
    Segretario
    Badgers Barn
    Farthings Paddock
    BA7 7QA Alford
    Somerset
    British42484650004
    HAMZEHPOUR, Tammy
    7816 Bush Lake Drive
    Bloomington
    Minnesota Mn 55438
    Usa
    Segretario
    7816 Bush Lake Drive
    Bloomington
    Minnesota Mn 55438
    Usa
    American64501790002
    ACHESON, William Brian
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    American100315920003
    APPEL, Robert Louis
    2 Sheridan Grange
    Broomhall Lane
    SL5 0BX Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    2 Sheridan Grange
    Broomhall Lane
    SL5 0BX Sunningdale
    Berkshire
    American86709370001
    BEST, Simon Peter Francis
    The Hollies
    Peters Green
    LU2 9QW Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Hollies
    Peters Green
    LU2 9QW Luton
    Bedfordshire
    United KingdomAustralian7869940001
    BRADLEY, Colin Walter
    Williamsgate
    The Street
    RG27 0PJ Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Williamsgate
    The Street
    RG27 0PJ Eversley
    Hampshire
    British70001440003
    COX, Kenneth Geoffrey
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    Amministratore
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish45253390001
    DUGGLEBY, Colin
    Red Cottages
    Pilcot Hill
    RG27 8SZ Dogmersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Red Cottages
    Pilcot Hill
    RG27 8SZ Dogmersfield
    Hampshire
    British69027230001
    FREEMAN, Timothy, Mr.
    94 Oak Hill Crescent
    IG8 9PQ Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    94 Oak Hill Crescent
    IG8 9PQ Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish141863550001
    FREEMAN, Timothy
    8 Raymond Avenue
    South Woodford
    E18 2HG London
    Amministratore
    8 Raymond Avenue
    South Woodford
    E18 2HG London
    British56917840001
    HIGGINS, Christopher James
    24 Ennismore Avenue
    GU1 1SR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    24 Ennismore Avenue
    GU1 1SR Guildford
    Surrey
    British115417740001
    HYNES, Stephen
    Oaklands The Rowans
    TW16 7QG Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    Oaklands The Rowans
    TW16 7QG Sunbury On Thames
    Middlesex
    British55171110001
    LUNDGREN, Jefrey Andrew
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish130391340002
    MCMILLAN, Eileen
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    Amministratore
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    British118951850003
    MELLOR, Luke Bartholomew
    55 Albion Drive
    EC2N 4AE London
    Amministratore
    55 Albion Drive
    EC2N 4AE London
    British48782560001
    NORDEEN, Christopher Jon
    9413 Brooke Drive
    Bethesda
    Maryland 20817 2109
    Usa
    Amministratore
    9413 Brooke Drive
    Bethesda
    Maryland 20817 2109
    Usa
    German61535870005
    SEARLE, Barry Roy
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    British70897720003

    RMAC 1999-NS2 ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of charge and assignment (the "deed of charge")
    Creato il 21 set 1999
    Consegnato il 27 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    (A) all moneys and liabilities whatsoever which from time to time become due, owing or payable by the issuer: (i)to the order of the trustee and/or any receiver under the deed of charge, the trust deed or the conditions at the times and in the manner provided therein; (ii)under or in respect of the notes; and (iii)to the trustee under the transaction documents, whether as principal or surety and whether or not directly with another. (B) all moneys and liabilities whatsoever which from time to time become due, owing or payable by the issuer to each of the other secured creditors in accordance respectively with each of the other documents (together the "secured amounts")
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit present and future in, to and under the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and all monies assured by or to become payable under the same and benefit of all covenants relating thereto - for full details see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan Trustees Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 27 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0