CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED

CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02196821
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CASTLEOAK CONSTRUCTION LIMITED15 mag 199615 mag 1996
    CASTLE CONSTRUCTION (SOUTH WALES) LIMITED08 feb 198808 feb 1988
    NETUNIQUE LIMITED20 nov 198720 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2020
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2021
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2022
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma24 mag 2022
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al10 mag 2021
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2025

    23 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2024

    29 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2023

    26 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    19 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2022

    35 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    104 pagineLIQ10

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 20 dic 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 28 ott 2021

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    14 pagineLIQ02

    Indirizzo della sede legale modificato da Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park Cardiff South Glamorgan CF23 8RA a 15 Canada Square London E14 5GL in data 11 nov 2021

    2 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 021968210012, creata il 30 set 2021

    13 pagineMR01

    Nomina di Mr Robert John Smith come amministratore in data 03 giu 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Colwyn Roy Knight come amministratore in data 03 giu 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lisa Veronica Gledhill come amministratore in data 03 giu 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Norman Duggan come amministratore in data 03 giu 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Katie Michelle Elizabeth Still come amministratore in data 24 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Norman Duggan come amministratore in data 07 mag 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert John Smith come amministratore in data 07 mag 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Colwyn Roy Knight come amministratore in data 07 mag 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Lisa Veronica Gledhill come amministratore in data 07 mag 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Katie Michelle Elizabeth Still come amministratore in data 14 set 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUGGAN, Andrew Norman
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    WalesBritish103404260001
    FOSTER, Paul Guy
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish138480900001
    KNIGHT, Colwyn Roy
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    WalesBritish228144720001
    SMITH, Robert John
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish284046520001
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Segretario
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    British19312940002
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Segretario
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    British19312940002
    JOHN, Dafydd Rhys
    Gwehelog
    NP15 1RB Usk
    Mulberry House
    Monmouthshire
    Segretario
    Gwehelog
    NP15 1RB Usk
    Mulberry House
    Monmouthshire
    British130454010002
    KNIGHT, Amanda Jayne
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Segretario
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    British78119010002
    KNIGHT, Amanda Jayne
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    Segretario
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    British78119010001
    KNIGHT, Melville William
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Segretario
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    British23297750005
    ROWLES, Paul
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    Segretario
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    British47041550002
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Amministratore
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    United KingdomBritish19312940002
    CURRIE, Craig
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish90119310003
    DUGGAN, Andrew Norman
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish103404260001
    GLEDHILL, Lisa Veronica
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish178456550002
    GREENSTREET, Simon David John
    Rumpus House
    Llandenny
    NP15 1DL Usk
    Monmouthshire
    Amministratore
    Rumpus House
    Llandenny
    NP15 1DL Usk
    Monmouthshire
    WalesBritish47041540007
    HOAD, Roger John
    4 Priory Way
    Langstone
    NP18 2JE Newport
    Amministratore
    4 Priory Way
    Langstone
    NP18 2JE Newport
    United KingdomBritish112194240001
    JOHN, Dafydd Rhys
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish130454010002
    JONES, Douglas Mark
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish61496560003
    KNIGHT, Colwyn Roy
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish228144720001
    KNIGHT, Colwyn Roy
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    Amministratore
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    WalesBritish23297760001
    KNIGHT, Melville William
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Amministratore
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    United KingdomBritish23297750005
    KNIGHT, Melville Roy
    4 Barton Bridge Rise
    NP5 2JU Raglan
    Gwent
    Amministratore
    4 Barton Bridge Rise
    NP5 2JU Raglan
    Gwent
    British9732680002
    LOUDEN, Nicholas William
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish137252480001
    MARCH, Eric Francis
    27 White Street
    SN10 4DP Market Lavington
    Wiltshire
    Amministratore
    27 White Street
    SN10 4DP Market Lavington
    Wiltshire
    EnglandBritish15192030002
    ROSSER, Karen Catherine
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish161080070001
    SMITH, Jonathan Mark
    3 Wellfield Close
    NP4 0SS Coed Y Paen
    Jasmine House
    Monmouthshire
    Amministratore
    3 Wellfield Close
    NP4 0SS Coed Y Paen
    Jasmine House
    Monmouthshire
    United KingdomBritish138228700001
    SMITH, Robert John
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish284046520001
    STEPHENS, Paul
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish95528060002
    STILL, Katie Michelle Elizabeth
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish269327810001
    SWAIN, Brian Macvicar
    Laheen
    Cansiron Lane
    RH19 3SD Ashurst Wood
    West Sussex
    Amministratore
    Laheen
    Cansiron Lane
    RH19 3SD Ashurst Wood
    West Sussex
    United KingdomAmerican22219950002
    WATKINS, Nigel Kenneth
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish187325680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Malthouse Avenue
    Pontprennau
    CF23 8RA Cardiff
    Raglan House
    Wales
    06 apr 2016
    Malthouse Avenue
    Pontprennau
    CF23 8RA Cardiff
    Raglan House
    Wales
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04188115
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    10 mag 201710 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 set 2021
    Consegnato il 04 ott 2021
    In corso
    Breve descrizione
    Security over cash deposit.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Chattels mortgage
    Creato il 31 ott 2002
    Consegnato il 31 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things being 1 x hp 9100C digital sender s/no. SJPX8001847, 1 x hp colour laserjet 8550N printer s/no. SJPMC438853, 1 x dell precision 340 dt P4 1.7GHZ/256K workstation/pc s/no. BD22HOJ (for further details of property charged please see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 31 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 01 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as icon house,cardiff gate business park,cardiff. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 30 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 giu 2008
    Assignment
    Creato il 02 mar 2001
    Consegnato il 02 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a construction contract
    Brevi particolari
    With full title guarantee assigns to the chargee the deposit of £150,000 credited to account number 21561102, designation royal bank of scotland re castle oak construction limited.
    Persone aventi diritto
    • Ledbury Health Limited
    Transazioni
    • 02 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposits
    Creato il 18 giu 1999
    Consegnato il 26 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the secured agreements referred to in this charge and/or the charge.
    Brevi particolari
    Fixed charge on the deposit of £4,000.00 per calendar month for twelve months commencing on the 1ST july 1999, and all entitlements to interest and the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the said deposit.
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company Limited
    Transazioni
    • 26 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 mar 1999
    Consegnato il 10 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or castleoak PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 32 endy mion mews hatfield herts. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 23 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,350 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The rent deposit of £1,350. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mole Valley District Council
    Transazioni
    • 23 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 1994
    Consegnato il 13 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4 barton bridge rise, raglan, gwent. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 28 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a plot 1 castle meadows raglan gwent with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1988
    Consegnato il 20 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on south side of station road abergavenny. Title no wa 359129 and/or the proceeds of sale (see doc M395-ref M289 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 nov 1988
    Consegnato il 22 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book and other debits uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 ott 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ryan Kevin Grant
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Sarah Elizabeth Collins
    2 Forbury Place, 33 Forbury Road
    Reading
    Praticante
    2 Forbury Place, 33 Forbury Road
    Reading

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0