CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02196821 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 10 Fleet Place EC4M 7QS London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CASTLEOAK CONSTRUCTION LIMITED | 15 mag 1996 | 15 mag 1996 |
| CASTLE CONSTRUCTION (SOUTH WALES) LIMITED | 08 feb 1988 | 08 feb 1988 |
| NETUNIQUE LIMITED | 20 nov 1987 | 20 nov 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2020 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2021 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 10 mag 2022 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 24 mag 2022 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 10 mag 2021 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2025 | 23 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2024 | 29 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2023 | 26 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 19 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2022 | 35 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 104 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 20 dic 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione delle attività | 14 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park Cardiff South Glamorgan CF23 8RA a 15 Canada Square London E14 5GL in data 11 nov 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 021968210012, creata il 30 set 2021 | 13 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert John Smith come amministratore in data 03 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Colwyn Roy Knight come amministratore in data 03 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Veronica Gledhill come amministratore in data 03 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Norman Duggan come amministratore in data 03 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Katie Michelle Elizabeth Still come amministratore in data 24 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Norman Duggan come amministratore in data 07 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert John Smith come amministratore in data 07 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colwyn Roy Knight come amministratore in data 07 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Lisa Veronica Gledhill come amministratore in data 07 mag 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Katie Michelle Elizabeth Still come amministratore in data 14 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUGGAN, Andrew Norman | Amministratore | Fleet Place EC4M 7QS London 10 | Wales | British | 103404260001 | |||||
| FOSTER, Paul Guy | Amministratore | Fleet Place EC4M 7QS London 10 | England | British | 138480900001 | |||||
| KNIGHT, Colwyn Roy | Amministratore | Fleet Place EC4M 7QS London 10 | Wales | British | 228144720001 | |||||
| SMITH, Robert John | Amministratore | Fleet Place EC4M 7QS London 10 | England | British | 284046520001 | |||||
| COAKLEY, Calvin Lloyd | Segretario | 44 Pentwyn Radyr CF15 8RE Cardiff | British | 19312940002 | ||||||
| COAKLEY, Calvin Lloyd | Segretario | 44 Pentwyn Radyr CF15 8RE Cardiff | British | 19312940002 | ||||||
| JOHN, Dafydd Rhys | Segretario | Gwehelog NP15 1RB Usk Mulberry House Monmouthshire | British | 130454010002 | ||||||
| KNIGHT, Amanda Jayne | Segretario | Wood Farm Gwehelog NP15 1RD Usk | British | 78119010002 | ||||||
| KNIGHT, Amanda Jayne | Segretario | Llanberis Monmouth Road NP15 2LA Raglan Monmouthshire | British | 78119010001 | ||||||
| KNIGHT, Melville William | Segretario | Wood Farm Gwehelog NP15 1RD Usk | British | 23297750005 | ||||||
| ROWLES, Paul | Segretario | 23 Hazel Close New Inn NP4 0RR Pontypool Torfaen | British | 47041550002 | ||||||
| COAKLEY, Calvin Lloyd | Amministratore | 44 Pentwyn Radyr CF15 8RE Cardiff | United Kingdom | British | 19312940002 | |||||
| CURRIE, Craig | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | England | British | 90119310003 | |||||
| DUGGAN, Andrew Norman | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 103404260001 | |||||
| GLEDHILL, Lisa Veronica | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 178456550002 | |||||
| GREENSTREET, Simon David John | Amministratore | Rumpus House Llandenny NP15 1DL Usk Monmouthshire | Wales | British | 47041540007 | |||||
| HOAD, Roger John | Amministratore | 4 Priory Way Langstone NP18 2JE Newport | United Kingdom | British | 112194240001 | |||||
| JOHN, Dafydd Rhys | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 130454010002 | |||||
| JONES, Douglas Mark | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 61496560003 | |||||
| KNIGHT, Colwyn Roy | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 228144720001 | |||||
| KNIGHT, Colwyn Roy | Amministratore | The Mount Castle Road NP15 2JZ Raglan Monmouthshire | Wales | British | 23297760001 | |||||
| KNIGHT, Melville William | Amministratore | Wood Farm Gwehelog NP15 1RD Usk | United Kingdom | British | 23297750005 | |||||
| KNIGHT, Melville Roy | Amministratore | 4 Barton Bridge Rise NP5 2JU Raglan Gwent | British | 9732680002 | ||||||
| LOUDEN, Nicholas William | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 137252480001 | |||||
| MARCH, Eric Francis | Amministratore | 27 White Street SN10 4DP Market Lavington Wiltshire | England | British | 15192030002 | |||||
| ROSSER, Karen Catherine | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 161080070001 | |||||
| SMITH, Jonathan Mark | Amministratore | 3 Wellfield Close NP4 0SS Coed Y Paen Jasmine House Monmouthshire | United Kingdom | British | 138228700001 | |||||
| SMITH, Robert John | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | England | British | 284046520001 | |||||
| STEPHENS, Paul | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 95528060002 | |||||
| STILL, Katie Michelle Elizabeth | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | 269327810001 | |||||
| SWAIN, Brian Macvicar | Amministratore | Laheen Cansiron Lane RH19 3SD Ashurst Wood West Sussex | United Kingdom | American | 22219950002 | |||||
| WATKINS, Nigel Kenneth | Amministratore | Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park CF23 8RA Cardiff South Glamorgan | England | British | 187325680001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castleoak Holdings Limited | 06 apr 2016 | Malthouse Avenue Pontprennau CF23 8RA Cardiff Raglan House Wales | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 10 mag 2017 | 10 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 30 set 2021 Consegnato il 04 ott 2021 | In corso | ||
Breve descrizione Security over cash deposit. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 31 ott 2002 Consegnato il 31 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels plant machinery and things being 1 x hp 9100C digital sender s/no. SJPX8001847, 1 x hp colour laserjet 8550N printer s/no. SJPMC438853, 1 x dell precision 340 dt P4 1.7GHZ/256K workstation/pc s/no. BD22HOJ (for further details of property charged please see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 31 mag 2002 Consegnato il 01 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as icon house,cardiff gate business park,cardiff. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 mag 2002 Consegnato il 30 mag 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 02 mar 2001 Consegnato il 02 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a construction contract | |
Brevi particolari With full title guarantee assigns to the chargee the deposit of £150,000 credited to account number 21561102, designation royal bank of scotland re castle oak construction limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over cash deposits | Creato il 18 giu 1999 Consegnato il 26 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the secured agreements referred to in this charge and/or the charge. | |
Brevi particolari Fixed charge on the deposit of £4,000.00 per calendar month for twelve months commencing on the 1ST july 1999, and all entitlements to interest and the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the said deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 03 mar 1999 Consegnato il 10 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or castleoak PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Flat 32 endy mion mews hatfield herts. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 17 lug 1998 Consegnato il 23 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,350 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The rent deposit of £1,350. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 ott 1994 Consegnato il 13 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 4 barton bridge rise, raglan, gwent. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 set 1993 Consegnato il 28 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a plot 1 castle meadows raglan gwent with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 30 nov 1988 Consegnato il 20 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land and buildings on south side of station road abergavenny. Title no wa 359129 and/or the proceeds of sale (see doc M395-ref M289 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 05 nov 1988 Consegnato il 22 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book and other debits uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0