SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02197707
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHRISTIAN PROJECTS LIMITED28 nov 198928 nov 1989
    CHRISTIAN PROJECT DEVELOPMENTS LIMITED24 nov 198724 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2011

    Stato del capitale al 22 set 2011

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    17 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Neil Midmer il 27 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    CHURCH, John Andrew
    1 Rectory Cottages
    Gedling
    NG4 4BH Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    1 Rectory Cottages
    Gedling
    NG4 4BH Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant59407160001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Secretary84003280001
    HENDERSON, David Greig
    154 Loughborough Road
    West Bridgford
    NG2 7JE Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    154 Loughborough Road
    West Bridgford
    NG2 7JE Nottingham
    Nottinghamshire
    British6112570001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305400001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishCompany Director103588940001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Amministratore
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    BritishCompany Director51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BORRETT, Nicholas John
    Dumble Cottage Water Lane
    Oxton
    NG25 0SH Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Dumble Cottage Water Lane
    Oxton
    NG25 0SH Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Architect1957140002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector111188390002
    HENDERSON, David Greig
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Amministratore
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    EnglandBritishConstruction Industry Consulta6112570002
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishFinancial Director15223790003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New ZealanderCompany Director5076900001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New ZealanderCompany Director80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishCompany Director103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishDirector77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    BritishDoctor Of Medicine34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director80445640001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 2004
    Consegnato il 28 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 28 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 ago 2002
    Consegnato il 03 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 03 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third guarantee and debenture
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 30 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Hillside nursing home bicester road aylesbury bucks t/n BM230735; old mendip hospital nr wells somerset t/n ST112935; gledhow christian nursing home gledhow grange brackenwood drive leeds t/n WYK637811. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 11 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee (as security agent for the beneficiaries) (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 gen 1999
    Consegnato il 20 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at gledhow grange leeds west yorkshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 feb 1998
    Consegnato il 06 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at ardenham lane aylesbury buvkinghamshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over building agreement
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 15 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a mortgage dated 2ND july 1996 and under this security
    Brevi particolari
    All estate interest benefit or right whatsoever of the company in a building agreement dated 7/2/97 between the company and williams developments limited relating to works on land to north west of main st,frodsham cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 15 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over building agreement
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 15 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a mortgage dated 7TH february 1997 and under this security
    Brevi particolari
    All interest,benefit or right whatsoever in a building agreement dated 29/1/97 between the company and design and build services limited relating to works on land at avonlodge motel wooton wawen stratford-u-avon,warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 15 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 13 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a avonlodge motel bearley cross wooton wawen stratford-upon-avon warwickshire t/n WK321558, specific charge the goodwill and connection of the business or businesses. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 13 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1996
    Consegnato il 04 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at the rear of main street frodsham t/no (part) CH3841779 CH363671 and CH390915 with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Plcas Trustee for Itself and Aib Finance Limited
    Transazioni
    • 04 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 feb 1996
    Consegnato il 29 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a land lying to the north west of main street frodsham CH390916 with the goodwill of any business from time to time at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 29 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over building agreement
    Creato il 17 nov 1995
    Consegnato il 01 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from trinity care PLC to the chargee under a mortgage dated 31ST march 1995 and all monies due from the company on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the estate interest and benefit and right of the company in a building agreement dated 25TH october 1995 relating to the development of a nursing home at churchfield park radford nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 23 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at 95 bristol road whitchurch wansdyke avon t/no.AV167313 and all buildings and other structures and goodwill. Fixed and floating charge over all plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land north of old frome road wells t/no.ST112935 and all buildings and other structures and goodwill. Fixed and floating charges over all plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 set 1995
    Consegnato il 21 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a lauriston hollington park st leonards on sea hastings sussex t/n HT11516 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over sale and purchase agreement
    Creato il 26 lug 1994
    Consegnato il 27 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal mortgage dated 1 july 1994 and this charge
    Brevi particolari
    Assignment of the benefit of a sale and purchase agreement dated 28 january 1994 as varied by a supplemental agreement dated 31 march 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 27 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over building agreement
    Creato il 01 lug 1994
    Consegnato il 09 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1. by way of assignment the benfit of a building agreement dated 18 may 1994 between the company and G. & J. seddon limited. 2. by way of assignment the benefit of a security bond dated 1 june 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1994
    Consegnato il 05 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. As trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property k/as nursing home at warford park,faulkners lane,mobberley,cheshire forming part of t/no.CH315687.by way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses from time to time carried on by or for the account of the company upon all or any part of the mortgaged property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 13 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on south west side of stoneyford road sutton in ashfield nottinghamshire.t/no.nt 232176. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 1993
    Consegnato il 13 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and trinity care limited to the chargee
    Brevi particolari
    The full benefit and advantage of a building agreement dated the 26 O7 1993.the full benefit and advantage of a surety bond dated 26 07 1993. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 13 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0