GALLERY CINEMAS LIMITED

GALLERY CINEMAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGALLERY CINEMAS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02199095
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di GALLERY CINEMAS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GALLERY CINEMAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Vantage London
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    England
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GALLERY CINEMAS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    C O CINEMAS LIMITED21 ott 198821 ott 1988
    CINEPLEX CINEMAS LIMITED24 giu 198824 giu 1988
    MONEYWIDE LIMITED26 nov 198726 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di GALLERY CINEMAS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GALLERY CINEMAS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al02 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma16 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al02 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per GALLERY CINEMAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Iscrizione dell'ipoteca 021990950011, creata il 02 dic 2024

    137 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 021990950009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 021990950010 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Scott Brooker come segretario in data 28 giu 2024

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr John Martin Henrich come segretario in data 28 giu 2024

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    6 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 021990950010, creata il 31 lug 2023

    149 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 021990950009, creata il 31 lug 2023

    147 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 021990950008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 021990950006 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roei Kaufman il 31 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 021990950007 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 021990950008, creata il 09 set 2022

    98 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Nomina di Scott Brooker come segretario in data 01 mar 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nigel Kravitz come segretario in data 01 mar 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Nigel Kravitz come segretario in data 27 gen 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Fiona Elizabeth Smith come segretario in data 27 gen 2022

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di GALLERY CINEMAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENRICH, John Martin
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Segretario
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    325235820001
    JONES, Shaun Alan
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Amministratore
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    EnglandBritishDirector245559840001
    KAUFMAN, Roei
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Amministratore
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    United KingdomRomanianAccountant 227938020002
    BROOKER, Scott
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Segretario
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    293118070001
    HEWETT, John Christopher
    Railway End 44 The Grip
    Linton
    CB1 6NR Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    Railway End 44 The Grip
    Linton
    CB1 6NR Cambridge
    Cambridgeshire
    British1934250001
    KRAVITZ, Nigel
    8th Floor Vantage London
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    Cineworld Group Plc
    United Kingdom
    Segretario
    8th Floor Vantage London
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    Cineworld Group Plc
    United Kingdom
    291881010001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Segretario
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    SMITH, Bernard Arthur
    12 North Holmes Close
    RH12 4HB Horsham
    West Sussex
    Segretario
    12 North Holmes Close
    RH12 4HB Horsham
    West Sussex
    British1678790001
    SMITH, Fiona Elizabeth
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Segretario
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    British182082970001
    TAYLOR, Margaret
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Segretario
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Irish46146250002
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Segretario
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    HAL MANAGEMENT LIMITED
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Segretario
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    2851030001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    United Kingdom
    Segretario
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04051235
    83864780002
    ABBOTT, Trevor Michael
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    BritishDirector35278820001
    BOWCOCK, Philip
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomBritishAccountant166007090001
    BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    Amministratore
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    BritishDirector39498750002
    BROOKMYRE, Charlotte Abigail
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    Amministratore
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    EnglandBritishChartered Accountant160575040004
    BURKE, Simon Paul
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    Amministratore
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    United KingdomIrishDirector30017870003
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Amministratore
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritishDirector68747470001
    DHADWAR, Sukhrajit Singh
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant98926850002
    DOEREN, William Bernard
    25 Ennismore Mews
    SW7 1AB London
    Amministratore
    25 Ennismore Mews
    SW7 1AB London
    AmericanCompany Director34151930001
    DURA, Jean-Marie
    99 Bis De La Croix Rousse
    69004 Lyon
    France
    Amministratore
    99 Bis De La Croix Rousse
    69004 Lyon
    France
    FrenchDirector67133410001
    EVANS, Martin John
    44 Heath Gardens
    TW1 4LZ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    44 Heath Gardens
    TW1 4LZ Twickenham
    Middlesex
    BritishFinance Director38925660001
    EYRE, Matthew Neil
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Amministratore
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    EnglandBritishDirector213190620001
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director61663230001
    JENKINS, Barry Charles
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    Amministratore
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    EnglandBritishManaging Director97730910001
    JONES, Richard David
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomBritishDirector45933780006
    KEREN, Merav
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Amministratore
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    United KingdomIsraeliFinancial Director199412670001
    LADD JNR, Alan
    640 San Vicente Boulevard
    Los Angeles California 90048
    FOREIGN
    Usa
    Amministratore
    640 San Vicente Boulevard
    Los Angeles California 90048
    FOREIGN
    Usa
    AmericanBusiness Executive17229690001
    LIEBERSON, Sanford
    11 St Marks Crescent
    NW1 7TS London
    Amministratore
    11 St Marks Crescent
    NW1 7TS London
    United KingdomBritishFilm Producer4177850001
    LION, Nir
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    Amministratore
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    England
    England
    EnglandIsraeliDirector241199260001
    MEEKER III, Charles Rutherford
    640 San Vicente Boulevard
    Los Angeles California 90048
    FOREIGN
    Usa
    Amministratore
    640 San Vicente Boulevard
    Los Angeles California 90048
    FOREIGN
    Usa
    AmericanBusiness Executive17229670001
    MEYER, Kenneth Harris
    8670 Wilshire Boulevard
    Beverly Hills
    California 90211
    Usa
    Amministratore
    8670 Wilshire Boulevard
    Beverly Hills
    California 90211
    Usa
    AmericanBusiness Executive16119720001
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    Amministratore
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    BritishAccountant70496800002
    SOMMERS, Michael John
    Beth House
    Norrels Drive, East Horsley
    KT24 5DR Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Beth House
    Norrels Drive, East Horsley
    KT24 5DR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director115290220001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GALLERY CINEMAS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    Middlesex
    06 apr 2016
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    8th Floor Vantage London
    Middlesex
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02201275
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GALLERY CINEMAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 dic 2024
    Consegnato il 11 dic 2024
    In corso
    Breve descrizione
    Pursuant to clause the instrument, the company charged certain properties including a property at brighton marina, brighton east, sussex, BN2 5UF with title number ESX207048. For further details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC, as Administrative Agent
    Transazioni
    • 11 dic 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2023
    Consegnato il 10 ago 2023
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The deed enclosed includes a legal mortgage and/or fixed charge over the property listed in schedule 2 and a fixed charge over trademarks owned by cineworld cinemas limited listed in schedule 6 with registration numbers: UK00002236467, UK00002410286, UK00906894109, UK00909254814, UK00909853921, UK00916344194, UK00003173915, UK00003210489 and UK00003276101. For more details refer to the deed.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 dic 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2023
    Consegnato il 03 ago 2023
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The deed enclosed includes a legal mortgage and/or fixed charge over the property listed in schedule 2 and a fixed charge over trademarks owned by cineworld cinemas limited listed in schedule 6 with registration numbers: UK00002236467, UK00002410286, UK00906894109, UK00909254814, UK00909853921, UK00916344194, UK00003173915, UK00003210489 and UK00003276101. For more details refer to the deed.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Celebrity Commercial Funding (Cayman) L.P.
    Transazioni
    • 03 ago 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 dic 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 set 2022
    Consegnato il 29 set 2022
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Amongst others, leasehold property bearing title no. ESX207048 with address: brighton marina, brighton, east sussex BN2 5UF. Please refer to the security instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Administrative and Collateral Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 29 set 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 nov 2020
    Consegnato il 23 nov 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3.2 of the instrument, the company has granted a charge over its leasehold with title number ESX207048.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 gen 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 feb 2018
    Consegnato il 07 mar 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold property bearing title no. ESX207048 located in the county/district of brighton with address: brighton marina, brighton, east sussex BN2 5UF. Please refer to schedule 2 of the security instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 04 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a debenture dated 1 december 2004
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 set 1997
    Consegnato il 26 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of each obligor (as defined) to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) or any of them under each or any of the financing documents (as defined)in each case together with all costs,charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Brevi particolari
    F/H property k/a the abc cinema new broadway ealing greater london t/n MX438267 and other f/h property l/h property k/a the mgm cinema arcadian centre hurst street birmingham and other l/h property please refer to form 395 for full details of charged property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 26 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 15 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the lenders (as defined therein) (or any of them) on any account whatsoever under each or any of the finance documents (as defined therein) (the "secured liabilities") provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that if it were so included, the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 lug 1995
    Consegnato il 11 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companythe "Security Agent"
    Transazioni
    • 11 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0