TRAFFIC FLOW LIMITED

TRAFFIC FLOW LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAFFIC FLOW LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02199330
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAFFIC FLOW LIMITED?

    • Costruzione di strade e autostrade (42110) / Costruzioni
    • Costruzione di ponti e gallerie (42130) / Costruzioni
    • Costruzione di opere idrauliche (42910) / Costruzioni
    • Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. (42990) / Costruzioni

    Dove si trova TRAFFIC FLOW LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MAZARS LLP
    Tower Bridge House
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAFFIC FLOW LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE CABIN COMPANY LIMITED16 mar 200116 mar 2001
    TRYFORMAT LIMITED27 nov 198727 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAFFIC FLOW LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAFFIC FLOW LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 set 2017

    9 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Mark Farrah come amministratore in data 13 ago 2017

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony James Jackson come amministratore in data 30 gen 2017

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU England a C/O Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD in data 08 ott 2016

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Kingsgate High Street Redhill RH1 1SG England a 5 Churchill Place Canary Wharf London E14 5HU

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 set 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di Deborah Jane Sawers come amministratore in data 12 set 2016

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    16 set 2016Clarification This document is a duplicate of form AP01 registered on 13/09/2016 for Deborah Sawers.

    Nomina di Deborah Jane Sawers come amministratore in data 12 set 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Bnoms Limited il 09 dic 2015

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 130 Wilton Road London SW1V 1LQ a 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU in data 09 dic 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ott 2015

    Stato del capitale al 27 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Bnoms Limited come segretario in data 01 ott 2015

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Gregory William Mutch come segretario in data 30 set 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ott 2014

    Stato del capitale al 17 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2013

    Stato del capitale al 18 ott 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TRAFFIC FLOW LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BNOMS LIMITED
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Segretario
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione624621
    174017860001
    SAWERS, Deborah Jane
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomNew ZealanderChartered Accountant214098940001
    CAMPBELL, Emma
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    Segretario
    3 Grimston Grange
    Sherburn Road
    LS24 9BX Tadcaster
    North Yorkshire
    154950260001
    CHURCH, Andrew Stuart Cunningham
    Gateways Stoney Wood
    Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Gateways Stoney Wood
    Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    British38865770003
    FARRELL, Amanda Jane
    4 Hobby Close
    WN7 2GL Leigh
    Gtr Manchester
    Segretario
    4 Hobby Close
    WN7 2GL Leigh
    Gtr Manchester
    BritishFinance Manager100265060001
    MORRIS, Philip Hugh
    Station Road
    RH1 1PQ Redhill
    86
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    RH1 1PQ Redhill
    86
    Surrey
    United Kingdom
    150918670001
    MUTCH, Gregory William
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Segretario
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    173317700001
    SWALES, David John
    7 The Dales
    HU16 5JN Cottingham
    North Humberside
    Segretario
    7 The Dales
    HU16 5JN Cottingham
    North Humberside
    British16622180001
    THRALL, Timothy Mark
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    Segretario
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    BritishAccountant81710370002
    ADAMS, Robert
    7 Isle Close
    Crowle
    DN17 4NR Scunthorpe
    Lincolnshire
    Amministratore
    7 Isle Close
    Crowle
    DN17 4NR Scunthorpe
    Lincolnshire
    EnglandBritishRail Engineer81709840001
    BIRSE, Peter Malcolm
    Langscott Lower Street
    Dittisham
    TQ6 0HY Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    Langscott Lower Street
    Dittisham
    TQ6 0HY Dartmouth
    Devon
    BritishDirector16622200002
    BUDDEN, Martin, M
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector127509870001
    DOWNING, David John
    235 The Ridgeway
    AL4 9XG St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    235 The Ridgeway
    AL4 9XG St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector16714470001
    FARRAH, Mark
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritishSurveyor97482250001
    GOOSE, David George
    Springfield House Brigg Road
    Wrawby
    DN20 8RD Brigg
    Ne Lincolnshire
    Amministratore
    Springfield House Brigg Road
    Wrawby
    DN20 8RD Brigg
    Ne Lincolnshire
    EnglandBritishDirector30725940001
    GRIFFIN, Michael Alan
    14 Coulson Drive
    Worle
    BS22 0QL Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    14 Coulson Drive
    Worle
    BS22 0QL Weston Super Mare
    Avon
    BritishDirector47698140001
    JACKSON, Anthony James
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritishDirector81709780001
    NORTON, Mark Stuart
    Fewston View
    3 Middle Ridge Farm Timble
    LS21 2NP Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fewston View
    3 Middle Ridge Farm Timble
    LS21 2NP Otley
    West Yorkshire
    BritishDirector75337820002
    SWALES, David John
    7 The Dales
    HU16 5JN Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    7 The Dales
    HU16 5JN Cottingham
    North Humberside
    BritishAccountant16622180001
    THRALL, Timothy Mark
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    Three Oaks
    Park Avenue Barlow
    YO8 8JH Selby
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant81710370002
    WATSON, Peter Gareth
    21 Eights Marina
    CB4 1ZA Cambridge
    Amministratore
    21 Eights Marina
    CB4 1ZA Cambridge
    BritishDirector63234090002
    WILLIAMSON, Louise
    13 Oldfield Road
    BA2 3ND Bath
    Avon
    Amministratore
    13 Oldfield Road
    BA2 3ND Bath
    Avon
    United KingdomBritishDirector59191120002

    TRAFFIC FLOW LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 05 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company respectively charged in the manner referred to in clause 3.1 of the debentures and clause 2 of the chattel mortgage all of its assets as more specifically therein referred to upon the terms in all respects therein contained. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equipment mortgage
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 05 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each and every birse group member from time to time to the secured parties (or any of them), under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee assigns the equipment, all right title benefit and interest in all insurances, and warranties of the equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 02 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20 x 9 a/v open plan office c/w jacklegs s/no 6/22796 20 x 9 a/v open plan office c/w jacklegs s/no 6/22795 16 x 9 (3+1) toilet c/w jacklegs s/no 5/22694 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 27 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The equipment being 20 x 9 a/v open plan office + jacklegs 6/22474, 20 x 9 a/v open plan office + jacklegs 6/22473, 20 x 9 a/v open plan office + jacklegs 6/22500, for details of further equipment charged please refer to the from 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 09 lug 2003
    Consegnato il 10 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20'X 9' drying room s/no 6/21337, 20' x 9' drying room s/no 6/21338, 24' x 10' welfare unit s/no 7/20883 (for further chattels charged refer to form 395).
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 07 lug 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things being 32' x 10' 782-10 1 HJ029. 32' x 10' 782-10 1 HJ030, 32' x 10' 782-12 1 HJ031 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 31 mar 2003
    Consegnato il 01 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) 3 32' x 10' wc units,ser/nos 438201,438202,438203; (ii) 3 32' x 10' drying rooms,ser/nos 438301,438302,438303; (iii) 3 32' x 10' wc/kitchen/office,ser/nos 438101,438102,438103 with all plant machinery and things thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 23 gen 2003
    Consegnato il 23 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 23 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 04 feb 1993
    Consegnato il 17 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over all credit balances and stocks and shares. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 17 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRAFFIC FLOW LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 set 2016Inizio della liquidazione
    07 nov 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0