SHOWPINE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHOWPINE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02200551
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHOWPINE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SHOWPINE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Offices Of Bdo Llp
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHOWPINE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TREATPOISE LIMITED30 nov 198730 nov 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHOWPINE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SHOWPINE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a The Offices of Bdo Llp Two Snowhill Birmingham B4 6GA in data 30 ago 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 ago 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2016

    Stato del capitale al 05 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagineAD03

    Cessazione della carica di Peter Robert Andrew come amministratore in data 17 lug 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Colin Richard Clapham come amministratore in data 17 lug 2015

    2 pagineAP01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2014

    Stato del capitale al 21 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Peter Carr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Anthony Carr il 31 mar 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Colin Richard Clapham il 28 mar 2011

    2 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di SHOWPINE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Other135438270002
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish9684390001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34521340004
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Segretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    DAVEY, Robert
    Double Waters
    Scaddens Lane
    BS27 3UR Rodney Stoke
    Somerset
    Segretario
    Double Waters
    Scaddens Lane
    BS27 3UR Rodney Stoke
    Somerset
    British7241580004
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Segretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Segretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Segretario
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    British573140004
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    SUNTER, Amanda Jane
    19 First Avenue
    CM12 9PT Billericay
    Essex
    Segretario
    19 First Avenue
    CM12 9PT Billericay
    Essex
    British44240520001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish113503830003
    BEATTY, David
    Swangles
    Cold Christmas Thundridge
    SG12 7SP Ware
    Herts
    Amministratore
    Swangles
    Cold Christmas Thundridge
    SG12 7SP Ware
    Herts
    British709400001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish125216670001
    CARR, Peter Anthony
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish130306120001
    DOUGLAS, Ian Mcnicol
    Ranworth Lodge Rock Lane
    Mucklestone
    TF9 4DU Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Ranworth Lodge Rock Lane
    Mucklestone
    TF9 4DU Market Drayton
    Shropshire
    United KingdomBritish1277320001
    ELLIS, Roy
    17 Lupin Ride
    RG45 6US Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    17 Lupin Ride
    RG45 6US Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish52288200001
    FRESHNEY, Michael John
    Apple Orchard 136 Brox Road
    Ottershaw
    KT16 0LG Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    Apple Orchard 136 Brox Road
    Ottershaw
    KT16 0LG Chertsey
    Surrey
    EnglandBritish45689190001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Amministratore
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    HOWARD, Martin John
    Friary Cottage
    Witham Friary
    BA11 5HD Frome
    Somerset
    Amministratore
    Friary Cottage
    Witham Friary
    BA11 5HD Frome
    Somerset
    United KingdomBritish467110001
    JENKINS, Stephen Adrian
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish49738660003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Amministratore
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish120602100002
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    British115863170001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Amministratore
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritish75750250002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    REDFERN, Peter Timothy
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    British74208670003
    ROSIER, Stephen James
    Roke House
    42 Millway Road
    SP10 3EU Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Roke House
    42 Millway Road
    SP10 3EU Andover
    Hampshire
    British27921120004
    SMITH, Graham Hammond
    The Granary
    Station Road Wellow
    BA2 8QB Bath
    Avon
    Amministratore
    The Granary
    Station Road Wellow
    BA2 8QB Bath
    Avon
    British36016160001
    SMITH, Paul Thomson
    22 Reynards Copse
    CO4 9UR Colchester
    Essex
    Amministratore
    22 Reynards Copse
    CO4 9UR Colchester
    Essex
    EnglandBritish82453060001
    SUNTER, Amanda Jane
    19 First Avenue
    CM12 9PT Billericay
    Essex
    Amministratore
    19 First Avenue
    CM12 9PT Billericay
    Essex
    British44240520001
    SUTCLIFFE, Ian Calvert
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish112534590002

    SHOWPINE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4 amos way sibsey boston lancashire and the proceeds of sale. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 1993
    Consegnato il 01 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5 the meads pitsea. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1993
    Consegnato il 10 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    35 st. Margarets drive sprowston norfolk and the proceeds of sale. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1993
    Consegnato il 10 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    53 keeling way,attleborough,norfolk and the proceeds of sale and fittings,furniture and equipment,utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 13 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20 richmond park attleborough norfolk and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 03 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    8 pheasant close mulbarton norfolk and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 03 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 lych close turnchapel plymouth and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 1992
    Consegnato il 03 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    104 cameron road chesham bucks and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1992
    Consegnato il 05 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    40 buckfast close fairscroft bromsgrove worcs and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 ott 1992
    Consegnato il 20 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3 riches close, tasburgh, norfolk and the proceeds of sale and fixtures and fittings. Furniture and equipment, utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 ago 1992
    Consegnato il 22 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hamewith the street hardwick norfolk andthe proceeds of sale an fittings furniture and equipment utensils by way of a fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ago 1992
    Consegnato il 13 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    87 olland road attleborough norfolk and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1992
    Consegnato il 01 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    25 damgate street wymondham norfolk and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment and utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1992
    Consegnato il 01 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Coral cottage silver street besthorpe norfolk and the proceeds of sale and fixtures and fittings furniture and equipment utensils by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 apr 1990
    Consegnato il 23 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 99 cottinghams drive hellesden, broadland norfolk fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 giu 1989
    Consegnato il 30 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that plot of f/h land situate at buckenham road, attleborough breckland, norfolk fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SHOWPINE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ago 2016Inizio della liquidazione
    12 lug 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0