KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02203878
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED?

    • Altri servizi di pulizia (81299) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O REDHALL GROUP PLC
    Unit 3 Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Russell David Haworth il 10 gen 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Wayne Pearson come amministratore in data 03 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Russell David Haworth come amministratore in data 03 nov 2018

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Philip Comer il 09 ago 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Christopher John Kelly come segretario in data 01 lug 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Simon Philip Comer come segretario in data 02 lug 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher John Kelly come amministratore in data 29 giu 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Philip Comer come amministratore in data 02 lug 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Brierley come amministratore in data 31 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Wayne Pearson come amministratore in data 19 mar 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN a C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA in data 05 ago 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2016

    Stato del capitale al 05 gen 2016

    • Capitale: GBP 99
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2015

    Stato del capitale al 08 gen 2015

    • Capitale: GBP 99
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    248232250001
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector206088760003
    HAWORTH, Russell David
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector201533400002
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187648460001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector94645950001
    LLOYD, Sheelagh
    The Barn
    Galltycwm Farm Bryn
    SA13 2SH Port Talbot
    West Glamorgan
    Segretario
    The Barn
    Galltycwm Farm Bryn
    SA13 2SH Port Talbot
    West Glamorgan
    British28101190002
    ROBSON, William
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    Segretario
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    British74793730002
    BOWEN, Scott Thomas
    17 Peterscroft Avenue
    Ashurst
    SO40 7AB Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    17 Peterscroft Avenue
    Ashurst
    SO40 7AB Southampton
    Hampshire
    BritishDirector28101200002
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishChief Executive54808010002
    FOSTER, Robert Simon
    Aish,
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    Amministratore
    Aish,
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector134973970001
    JOHN, Malcolm
    8 Jessie Terrace
    SO14 3EF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    8 Jessie Terrace
    SO14 3EF Southampton
    Hampshire
    BritishDirector28101220002
    JORDAN, Roy Gregory
    40 High Street
    LE17 6LH Husbands Bosworth
    Leicestershire
    Amministratore
    40 High Street
    LE17 6LH Husbands Bosworth
    Leicestershire
    UsaCompany Director52042650003
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director188444350001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director94645950001
    LLOYD, Kenneth Sidney
    The Barn
    Galltycwm Farm Bryn
    SA13 2SH Port Talbot
    West Glamorgan
    Amministratore
    The Barn
    Galltycwm Farm Bryn
    SA13 2SH Port Talbot
    West Glamorgan
    BritishDirector28101210002
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    England
    United KingdomIrishDirector106172200001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector212154420001
    ROBSON, William
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    Amministratore
    Woodlands
    Main Street
    LE7 9YB Skeffington
    Leicestershire
    BritishCompany Director74793730002
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector58727820002

    Chi sono le persone con controllo significativo di KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 apr 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione263995
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    KLEENCO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13/02/01 (the agreement)
    Creato il 16 nov 2004
    Consegnato il 18 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 13 february 2001
    Creato il 24 ago 2004
    Consegnato il 14 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mag 2001
    Consegnato il 30 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 1990
    Consegnato il 12 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or avalon insulation services LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings at llewellyns quay, port talbot, west glamorgan title WA545494.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 1989
    Consegnato il 17 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sub-lease over the stores buildings llewellyns quay port talbot.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 05 feb 1988
    Consegnato il 12 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book and other debts & a floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0