OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED

OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02206221
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED?

    • (6340) /

    Dove si trova OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lhr1 145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OUGHTRED & HARRISON (FORWARDING) LIMITED10 feb 198810 feb 1988
    MAJORSTAGE LIMITED16 dic 198716 dic 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ott 2010

    Stato del capitale al 27 ott 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2009 al 30 dic 2009

    3 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Carr il 11 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart Innes il 11 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Fisher il 11 dic 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Paul Revill come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    19 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARR, Martin
    Fairfax Road
    TW11 9BU Teddington
    153a
    Middlesex
    Segretario
    Fairfax Road
    TW11 9BU Teddington
    153a
    Middlesex
    British48809650004
    CARR, Martin
    145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Lhr1
    Middlesex
    Amministratore
    145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Lhr1
    Middlesex
    EnglandBritish48809650004
    FISHER, Colin
    145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Lhr1
    Middlesex
    Amministratore
    145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Lhr1
    Middlesex
    EnglandBritish99054420003
    INNES, Stuart
    145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Lhr1
    Middlesex
    Amministratore
    145 Faggs Road
    TW14 0LZ Feltham
    Lhr1
    Middlesex
    United KingdomBritish122428800002
    HARRISON, Linda Rosina
    11 Stratton Park
    HU14 3NN Swanland
    East Yorkshire
    Segretario
    11 Stratton Park
    HU14 3NN Swanland
    East Yorkshire
    British53208180001
    HARRISON, Paul Leslie
    7 Chapelry Garth
    HU12 8LR Hedon
    East Yorkshire
    Segretario
    7 Chapelry Garth
    HU12 8LR Hedon
    East Yorkshire
    British86555890002
    PRENDERGAST, Ronald Joseph
    Old School
    Blackloft
    DN14 7YW Goole
    Humberside
    Segretario
    Old School
    Blackloft
    DN14 7YW Goole
    Humberside
    British40668600002
    WOODALL, George Simpson
    Knockeen
    Ings Lane Keyingham
    HU12 9RN Hull
    East Yorkshire
    Segretario
    Knockeen
    Ings Lane Keyingham
    HU12 9RN Hull
    East Yorkshire
    British99054490001
    COPLAND, Philip
    8 Battle Close
    Sarisbury Green
    SO31 7ZF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    8 Battle Close
    Sarisbury Green
    SO31 7ZF Southampton
    Hampshire
    British71337970002
    CRANE, Ernest Frank
    71 Village Road
    HU8 8QS Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    71 Village Road
    HU8 8QS Hull
    East Yorkshire
    British17816990001
    GILBERT, James
    37 Laburnum Grove
    Horbury
    WF4 6HG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    37 Laburnum Grove
    Horbury
    WF4 6HG Wakefield
    West Yorkshire
    British55851020001
    HARRISON, Geoffrey Arthur
    3 Tranby Lodge Gardens
    HU13 0TL Hessle
    East Yorkshire
    Amministratore
    3 Tranby Lodge Gardens
    HU13 0TL Hessle
    East Yorkshire
    United KingdomBritish1620810001
    HUGHAN, Keith Robert
    L37
    Amministratore
    L37
    British99641260002
    MARSHALL, Simon Andrew
    286 Station Road
    New Waltham
    DN36 4QQ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    286 Station Road
    New Waltham
    DN36 4QQ Grimsby
    North East Lincolnshire
    British1620820001
    PLATTS, Richard Colton
    Brambungs 10 Routh Avenue
    Purdis Farm
    IP3 8UZ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Brambungs 10 Routh Avenue
    Purdis Farm
    IP3 8UZ Ipswich
    Suffolk
    British17817020001
    REVILL, Paul Eugene
    708 Beverley High Road
    HU6 7JG Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    708 Beverley High Road
    HU6 7JG Hull
    East Yorkshire
    British17816980002
    SHEEKEY, Geoffrey Leslie
    29 Mead Walk
    Anlaby Park
    HU4 6XE Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    29 Mead Walk
    Anlaby Park
    HU4 6XE Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish14529640001
    WOODALL, George Simpson
    Knockeen
    Ings Lane Keyingham
    HU12 9RN Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    Knockeen
    Ings Lane Keyingham
    HU12 9RN Hull
    East Yorkshire
    British99054490001

    OUGHTRED & HARRISON (SHIPPING) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Trust debenture
    Creato il 09 ago 2004
    Consegnato il 18 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Oughtred and Harrison Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 ago 2004
    Consegnato il 13 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ago 2004
    Consegnato il 13 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 2001
    Consegnato il 27 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Oughtred & Harrison Limited
    Transazioni
    • 27 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0