RCHL OLD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRCHL OLD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02207611
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RCHL OLD LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova RCHL OLD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Brookfield Court Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RCHL OLD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RURAL INSURANCE GROUP LIMITED01 nov 199501 nov 1995
    RAPID HOME SERVICES LIMITED07 giu 198807 giu 1988
    RAPID 5025 LIMITED21 dic 198721 dic 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di RCHL OLD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RCHL OLD LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al21 dic 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per RCHL OLD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 mar 2023 al 29 set 2023

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 mar 2022

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Timothy John Smyth come amministratore in data 24 ott 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lance Douglas Harvey come amministratore in data 24 ott 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Marshall Coates come amministratore in data 24 ott 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Penelope Jane Fullerton come segretario in data 24 ott 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Shane O’Neill come amministratore in data 24 ott 2022

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a Brookfield Court Selby Road Garforth Leeds LS25 1NB in data 26 set 2022

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 mar 2021

    24 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Penelope Jane Pullerton il 01 giu 2022

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Elizabeth Anne Brophy come segretario in data 31 mag 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Penelope Jane Pullerton come segretario in data 01 giu 2022

    2 pagineAP03

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2021 al 30 mar 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Allan Crawford Adamson Gribben come amministratore in data 22 giu 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Malachy Paul Smith come amministratore in data 01 set 2020

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a 3.1 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG in data 17 ago 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Carrwood Park Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG England a 3.1 Selby Road Swillington Common Leeds West Yorkshire LS15 4LG in data 17 ago 2020

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di RCHL OLD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    O’NEILL, Shane
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    Amministratore
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    EnglandIrishCompany Director301566010001
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    BritishCompany Secretary139352410001
    BROPHY, Elizabeth Anne
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    247169000001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Beck Road
    BD16 3JN Bingley
    Holroyd House
    England
    Segretario
    Beck Road
    BD16 3JN Bingley
    Holroyd House
    England
    296527810002
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    184069040001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Segretario
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Segretario
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    185562630001
    WEAVER, Clare Louise
    27 Scholars Walk
    GU2 7TR Guildford
    Surrey
    Segretario
    27 Scholars Walk
    GU2 7TR Guildford
    Surrey
    BritishCompany Secretary66552530002
    WILLIAMS, Basil Frederick
    Homeland
    48 Dorking Road
    KT23 4PD Great Bookham
    Surrey
    Segretario
    Homeland
    48 Dorking Road
    KT23 4PD Great Bookham
    Surrey
    British254500001
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    170322470001
    PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    Segretario
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    107712310001
    THOMAS EGGAR SECRETARIES LIMITED
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    Segretario
    The Corn Exchange
    Baffins Lane
    PO19 1GE Chichester
    West Sussex
    37896530011
    BARCLAY, Ian James
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishManaging Director184779440002
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Amministratore
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritishDirector135540180002
    BIBBY, John
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    BritishCompany Director27995540003
    BLACKHAM, Christopher Layton
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishNon Executive Director140582420001
    CAHOON, David
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishManaging Director238359930001
    COATES, Graham Marshall
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    Amministratore
    Selby Road
    Garforth
    LS25 1NB Leeds
    Brookfield Court
    England
    United KingdomBritishNon Executive Director261903060001
    COUGHLIN, John Colin
    Whitehouse Farm Wivenhoe Road
    Crockleford Heath
    CO7 7BG Elmstead Market
    Essex
    Amministratore
    Whitehouse Farm Wivenhoe Road
    Crockleford Heath
    CO7 7BG Elmstead Market
    Essex
    BritishCompany Director38736680001
    COUTTS, Arthur Charles
    7 Freshwell Gardens
    West Horndon
    CM13 3NG Brentwood
    Essex
    Amministratore
    7 Freshwell Gardens
    West Horndon
    CM13 3NG Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director25601450001
    DAVEY, Jonathan Mark
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    Amministratore
    6 Mill Close Lane
    Patrick Brompton
    DL8 1AJ Bedale
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81484820003
    DUBLON, Alan James
    35 Bertram Road
    EN1 1LR Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    35 Bertram Road
    EN1 1LR Enfield
    Middlesex
    BritishInsurance Broker66212050001
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director184068890001
    GRIBBEN, Allan Crawford Adamson
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Selby Road
    Swillington Common
    LS15 4LG Leeds
    3.1 Carrwood Park
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishChairman208728570001
    GYNGELL, David Edward
    Sheepcote Farm House Sheepcote Lane
    BR5 4ET Orpington
    Kent
    Amministratore
    Sheepcote Farm House Sheepcote Lane
    BR5 4ET Orpington
    Kent
    BritishCompany Director25601430001
    HARVEY, Lance Douglas
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Hornbeam Park
    HG2 8RE Harrogate
    The Hamlet
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishNon Executive Director21625300004
    HARVEY, Lance Douglas
    The Bay House
    Main Road Flax Bourton
    BS48 3QQ Bristol
    Amministratore
    The Bay House
    Main Road Flax Bourton
    BS48 3QQ Bristol
    EnglandBritishCompany Director21625300004
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Amministratore
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    BritishAccountant79523100001
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishExecutive Chairman28375870003
    JAMES, Philip William Henry
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    Amministratore
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    BritishInsurance Broker33901640005
    KEATING, Michael Samuel
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector135065160001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Amministratore
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    BritishInsurance Executive127332980001
    KING, Michael Henry
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    Amministratore
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    BritishCompany Director14395670002
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director233726140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RCHL OLD LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pbs Holdings Limited
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    06 apr 2016
    Gibraltar Island Road, Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUk Register Of Companies
    Numero di registrazione05297966
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0