DYNIX LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDYNIX LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02207720
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DYNIX LTD?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova DYNIX LTD?

    Indirizzo della sede legale
    c/o SIRSIDYNIX
    54 Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DYNIX LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EPIXTECH LTD02 feb 200002 feb 2000
    AMERITECH LIBRARY SERVICES LTD. 21 mar 199721 mar 1997
    DYNIX LIBRARY SYSTEMS (UK) LIMITED25 mar 198825 mar 1988
    BROADURGENT LIMITED23 dic 198723 dic 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di DYNIX LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per DYNIX LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2013

    Stato del capitale al 30 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Stato del capitale al 25 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ott 2013

    • Capitale: GBP 609,001
    4 pagineSH01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 20/09/2013
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Nomina di William Charles Davison Jr come amministratore in data 24 feb 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gary Mark Rautenstrauch come amministratore in data 24 feb 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Chequers St Marys Way Chesham Buckinghamshire HP5 1LL in data 24 feb 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di DYNIX LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GARDINER, John Houston, Mr.
    c/o Sirsidynix
    Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    54
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Sirsidynix
    Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    54
    United Kingdom
    146655780001
    DAVISON JR, William Charles
    c/o Sirsidynix
    Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    54
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Sirsidynix
    Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    54
    United Kingdom
    United StatesAmerican167741700001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    BEZAULT, Sandra Gwat Tjhing
    Poortsebos 5
    3951 Bk Maarn
    The Netherlands
    Segretario
    Poortsebos 5
    3951 Bk Maarn
    The Netherlands
    British40394360001
    BRECK, David M, Mr.
    368 North 960 East
    84062 Pleasant Grove
    Not Applicable
    Utah
    Usa
    Segretario
    368 North 960 East
    84062 Pleasant Grove
    Not Applicable
    Utah
    Usa
    Other139205340001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Segretario
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    ELDER, Andrew
    Quay South Salamander Quay
    Park Lane Harefield
    UB9 6NY Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    Quay South Salamander Quay
    Park Lane Harefield
    UB9 6NY Uxbridge
    Middlesex
    British22708030001
    FARRINGTON, David John
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    British13372050001
    GETHIN, Peter Eric
    213 Darkes Lane
    EN6 1BX Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    213 Darkes Lane
    EN6 1BX Potters Bar
    Hertfordshire
    British8538600001
    IVEY, Jeffrey
    32 Larchmoor Park
    Gerrards Cross Road
    SL2 4EY Stoke Poges
    Buckinghamshire
    Segretario
    32 Larchmoor Park
    Gerrards Cross Road
    SL2 4EY Stoke Poges
    Buckinghamshire
    Australian73092470001
    MEHTA, Mrugesh
    5 Mentmore View
    HP23 4HR Tring
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Mentmore View
    HP23 4HR Tring
    Hertfordshire
    British60311150002
    RYAN, Sally Ann
    95 Clapham Common West Side
    SW4 9AZ London
    Segretario
    95 Clapham Common West Side
    SW4 9AZ London
    British56564050001
    BLOUNT, Jack
    2072 Mahre Drive
    Park City
    Utah 84608
    Usa
    Amministratore
    2072 Mahre Drive
    Park City
    Utah 84608
    Usa
    Us Citizen85636660001
    BRADY, Arthur
    2 Fallowfield Close
    Harefield
    UB9 6QE Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    2 Fallowfield Close
    Harefield
    UB9 6QE Uxbridge
    Middlesex
    British40183940001
    CARDEN, Mark Thomas Jan
    Barnane House Tickmorend
    Horsley
    GL6 0PE Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Barnane House Tickmorend
    Horsley
    GL6 0PE Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish44874740001
    DIMANT, Nicholas Leigh
    19 Finchley Way
    N3 1AG London
    Amministratore
    19 Finchley Way
    N3 1AG London
    EnglandBritish8538590002
    DOWNIE, William
    The Stable,
    Perton, Stoke Edith
    HR1 4HP Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Stable,
    Perton, Stoke Edith
    HR1 4HP Hereford
    Herefordshire
    British75847350001
    ELDER, Andrew
    Tigharry 8 Turnstone Close
    Winnersh
    RG11 5LQ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Tigharry 8 Turnstone Close
    Winnersh
    RG11 5LQ Wokingham
    Berkshire
    British59273640001
    EZEKIEL, Christopher
    3 Lingard House
    Marshfield Street
    E14 3HH London
    Amministratore
    3 Lingard House
    Marshfield Street
    E14 3HH London
    United KingdomBritish51046530003
    FORTUNE, Michael
    1 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    Hertfordshire
    British46859460001
    GETHIN, Peter Eric
    213 Darkes Lane
    EN6 1BX Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    213 Darkes Lane
    EN6 1BX Potters Bar
    Hertfordshire
    British8538600001
    MACDONALD, Thomas William
    347 East 1090 North
    84057 Orem
    Utah
    Usa
    Amministratore
    347 East 1090 North
    84057 Orem
    Utah
    Usa
    American40984850001
    MCCAUSLAND, Dean Alexander
    36 Carver Road
    Wellesly
    Massachusetts 02481
    Usa
    Amministratore
    36 Carver Road
    Wellesly
    Massachusetts 02481
    Usa
    American112104500001
    PATTERSON, Iain Armorer
    Otterburn
    2 Cumberland Close
    HP21 7HH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Otterburn
    2 Cumberland Close
    HP21 7HH Aylesbury
    Buckinghamshire
    British70074960001
    PORTER, Lana, President
    1127 Courtland Place
    60504 Avora
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    1127 Courtland Place
    60504 Avora
    Illinois
    Usa
    American51512340001
    QUARTON, Thomas
    4149 East Prospector Drive
    84121 Salt Lake City
    Ut
    Usa
    Amministratore
    4149 East Prospector Drive
    84121 Salt Lake City
    Ut
    Usa
    American44283040001
    RANCROFT, William Marler
    Dynix Management Inc
    4345 North Windsor Provo Utah 84606
    U S A
    Amministratore
    Dynix Management Inc
    4345 North Windsor Provo Utah 84606
    U S A
    Canadian22708040001
    RAUTENSTRAUCH, Gary Mark, Mr.
    c/o Sirsidynix
    Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    54
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Sirsidynix
    Clarendon Road
    WD17 1DU Watford
    54
    United Kingdom
    UsaUnited States82766870001
    RYAN, Sally Ann
    95 Clapham Common West Side
    SW4 9AZ London
    Amministratore
    95 Clapham Common West Side
    SW4 9AZ London
    British56564050001
    SHETH, Brian
    59 Lupine Ave
    Apartment 501
    FOREIGN California
    San Franciso 94118
    Usa
    Amministratore
    59 Lupine Ave
    Apartment 501
    FOREIGN California
    San Franciso 94118
    Usa
    American120515160001
    SLOAN, Roger
    2262 East High Ridge Lane
    Sandy Utah 84092
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    2262 East High Ridge Lane
    Sandy Utah 84092
    FOREIGN Usa
    American40183630001
    SMITH, Larry D
    117 Maximillion Drive
    Madison
    Alabama
    35758
    Usa
    Amministratore
    117 Maximillion Drive
    Madison
    Alabama
    35758
    Usa
    American107125410001
    SMITH, Robert
    25 Vista Del Sol
    Mill Valley
    California
    94941
    Usa
    Amministratore
    25 Vista Del Sol
    Mill Valley
    California
    94941
    Usa
    American134493060001
    SOMMERS, Patrick Charles
    18 Ledge View Drive
    Huntsville
    Alabama
    35802
    Usa
    Amministratore
    18 Ledge View Drive
    Huntsville
    Alabama
    35802
    Usa
    American107125530001
    SOWUL, Christian
    150 California St,
    19th Floor
    FOREIGN San Francisco
    Ca 94111
    Usa
    Amministratore
    150 California St,
    19th Floor
    FOREIGN San Francisco
    Ca 94111
    Usa
    United States120514960001

    DYNIX LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 02 gen 2002
    Consegnato il 07 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £13,000 credited to account designation 83623396 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 set 1993
    Consegnato il 17 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The due performance and observance by the company of the covenants agreements and conditions to salamander investments limited
    Brevi particolari
    £80,000.
    Persone aventi diritto
    • Salamander Investments Limited
    Transazioni
    • 17 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 09 mar 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £15,000.00 credited to account number /designated 12184575 with the bank together with all sums in the future credited to that account and including all interest accrued or accruing in the future on the account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 09 set 1991
    Consegnato il 12 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees supplemental to a lease dated 9.9.91 and under the terms of this deed.
    Brevi particolari
    The sum of £7,000 together with the further sum or sums covenanted to be paid under the terms of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Salamander Investments Limited
    Transazioni
    • 12 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 09 set 1991
    Consegnato il 12 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £14,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 9.9.91 and under the terms of the deed.
    Brevi particolari
    The sum of £14,000 together with the further sum or sums covenanted to be paid under the terms of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Salamander Investments Limited
    Transazioni
    • 12 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 14 ago 1991
    Consegnato il 20 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. The deposit means the debt owing to the company by the bank or any party. (Please see m 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 mag 1990
    Consegnato il 30 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of a designated account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 09 mar 1990
    Consegnato il 20 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0