SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02211403 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
- Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Farnborough Business Park 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Hampshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INC RESEARCH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED | 31 gen 2012 | 31 gen 2012 |
| KENDLE CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED | 17 ott 2006 | 17 ott 2006 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES CLINICAL SERVICES INTERNATIONAL LTD | 29 set 2005 | 29 set 2005 |
| INVERESK RESEARCH LIMITED | 02 lug 2001 | 02 lug 2001 |
| CLINTRIALS RESEARCH LIMITED | 25 mar 1994 | 25 mar 1994 |
| CLINTRIALS LIMITED | 16 mar 1992 | 16 mar 1992 |
| CLINICAL RESEARCH INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED | 25 mar 1988 | 25 mar 1988 |
| ALIGNBECK LIMITED | 18 gen 1988 | 18 gen 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 22 apr 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 33 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Syneos Health, Inc come persona con controllo significativo il 07 mag 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nyla Natalie Donna Maria Singh come segretario in data 05 feb 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Kirstin Maura Mackenzie Connell come amministratore in data 05 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Nyla Natalie Donna Maria Singh come amministratore in data 05 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 30 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Farnborough Business Park Pinehurst Road Farnborough GU14 7BF England a Farnborough Business Park 1 Pinehurst Road Farnborough Hampshire GU14 7BF in data 04 giu 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Riverview the Meadows Business Park Station Approach Camberley Surrey GU17 9AB a Farnborough Business Park Pinehurst Road Farnborough GU14 7BF in data 30 mag 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Inc Research Holdings, Inc come persona con controllo significativo il 04 gen 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Alistair John Macdonald il 01 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 32 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 31 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNELL, Kirstin Maura Mackenzie | Amministratore | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | England | British | 121742610001 | |||||
| MACDONALD, Alistair John | Amministratore | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | England | British | 177452780002 | |||||
| SINGH, Nyla Natalie Donna Maria | Amministratore | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152049680001 | |||||
| COWAN, Desmond Joseph Paul Edward | Segretario | 52 Leith Walk EH6 5HW Edinburgh Midlothian | British | 83009100001 | ||||||
| FRENCH, Charlotte Ann | Segretario | Hudson Cottage Howsham YO6 7PH York North Yorkshire | British | 35214860001 | ||||||
| HARRISON, Leigh Gordon | Segretario | Peak House The Ridge, Cold Ash RG18 9HZ Thatcham Berkshire | British | 71250990001 | ||||||
| JOHST, David P | Segretario | 7 Meadow View Lane Andover Massachusetts 01810 U S A | American | 101051040001 | ||||||
| JONES, Angela Margaret | Segretario | The Beren Hatchgate Farm Cockpole Green Wargrave RG10 8NE Reading Berkshire | British | 35510100002 | ||||||
| LESLIE, Stewart Gordon | Segretario | 11 Walker Street EH3 7NE Edinburgh Midlothian | British | 66170500001 | ||||||
| MOORE, Douglas Frank | Segretario | Welham Hall Welham YO17 9QF Malton North Yorkshire | British | 7282400001 | ||||||
| SAYERS, James Christopher | Segretario | 5 Whitchurch Close SL6 7TZ Maidenhead Berkshire | British | 36434820001 | ||||||
| SHAW, William Lawson, Dr | Segretario | 2 Autumn Walk SL6 4ND Maidenhead Berkshire | British | 48559390005 | ||||||
| SINGH, Nyla Natalie Donna Maria | Segretario | 1 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Farnborough Business Park Hampshire United Kingdom | British | 177453250001 | ||||||
| SINGH, Nyla Natalie | Segretario | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | British | 53140790003 | ||||||
| WALL, Karen Malinda | Segretario | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | British | 162650850001 | ||||||
| WILLIAMS, Nigel James, Dr | Segretario | Slievehamon Oakleigh Road Hatch End HA5 4HB Pinner Middlesex | British | 58705320001 | ||||||
| YENDELL, Timothy Patrick | Segretario | 64 Donnington Gardens RG1 5LZ Reading Berkshire | British | 64274200001 | ||||||
| ACKERMAN, Thomas Francis | Amministratore | 11 Athertone Circle Lynnfield Massachusetts 01940 U S A | American | United States | 101051180001 | |||||
| BERGEN, Christopher | Amministratore | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 62057130002 | |||||
| BOYCE, Alan James | Amministratore | Cambrian Close GU15 3LD Camberley 35 Surrey | United Kingdom | British | 78141200001 | |||||
| BRENKERT III, Karl | Amministratore | 981 Paxton Lake Drive Loveland Ohio 45140 Usa | American | 86872650002 | ||||||
| CHEESMAN, Keith A | Amministratore | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 138222390001 | |||||
| COWAN, Desmond Joseph Paul Edward | Amministratore | 52 Leith Walk EH6 5HW Edinburgh Midlothian | British | 83009100001 | ||||||
| DE WITT, Jan, Dr | Amministratore | Charlotte De Bourbonlaan 3708 CD Zeist Holland | Dutch | 58705310001 | ||||||
| FOSTER, James Clifford | Amministratore | 16 Hancock Road Weston Massachusetts 02493 U S A | Usa | 101050900001 | ||||||
| GANLEY, John Leo | Amministratore | Wedgefield Plantation Georgetown South Carolina 29440 FOREIGN Usa | Us Citizen | 7518960001 | ||||||
| GILL, David Neil | Amministratore | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 167395680001 | |||||
| GOODMAN, Nigel | Amministratore | 52 Westover Road SW18 2RH London | British | 60771380001 | ||||||
| HARRISON, Leigh Gordon | Amministratore | Peak House The Ridge, Cold Ash RG18 9HZ Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 71250990001 | |||||
| JOHST, David P | Amministratore | 7 Meadow View Lane Andover Massachusetts 01810 U S A | American | American | 101051040001 | |||||
| JONES, Angela Margaret | Amministratore | The Beren Hatchgate Farm Cockpole Green Wargrave RG10 8NE Reading Berkshire | British | 35510100002 | ||||||
| KENDLE, Candace | Amministratore | The Meadows Business Park Station Approach GU17 9AB Camberley Riverview Surrey United Kingdom | Usa | United States | 62038310002 | |||||
| KERKHOF, Glenn Cornelis | Amministratore | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | Netherlands | 99733300002 | ||||||
| KERKHOF, Glenn Cornelis | Amministratore | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | Netherlands | 99733300002 | ||||||
| LESLIE, Stewart Gordon | Amministratore | 11 Walker Street EH3 7NE Edinburgh Midlothian | British | 66170500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syneos Health, Inc | 06 apr 2016 | Silverside Road Tatnall Building #104 Wilmington 3411 De 19810 United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 lug 2010 Consegnato il 18 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to one or more lenders or their respective affiliates on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures & equipment see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 ago 2006 Consegnato il 05 set 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower and the other loan parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A collateral agreement | Creato il 30 lug 2003 Consegnato il 16 ago 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrowers or any of their subsidiaries to the lenders or the agents under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right title and interest in the following property now owned or at any time acquired by the grantor after the date of the collateral agreement, all accounts all cash and currency all chattel paper all commercial tort claims all deposit accounts all documents all equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 lug 2003 Consegnato il 16 ago 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 giu 2002 Consegnato il 10 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0