SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED

SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02211403
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    • Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Farnborough Business Park
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Hampshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INC RESEARCH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED31 gen 201231 gen 2012
    KENDLE CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED17 ott 200617 ott 2006
    CHARLES RIVER LABORATORIES CLINICAL SERVICES INTERNATIONAL LTD29 set 200529 set 2005
    INVERESK RESEARCH LIMITED02 lug 200102 lug 2001
    CLINTRIALS RESEARCH LIMITED25 mar 199425 mar 1994
    CLINTRIALS LIMITED16 mar 199216 mar 1992
    CLINICAL RESEARCH INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED25 mar 198825 mar 1988
    ALIGNBECK LIMITED18 gen 198818 gen 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 apr 2020

    • Capitale: GBP 1.3831
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    33 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Syneos Health, Inc come persona con controllo significativo il 07 mag 2018

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Nyla Natalie Donna Maria Singh come segretario in data 05 feb 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Kirstin Maura Mackenzie Connell come amministratore in data 05 feb 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Nyla Natalie Donna Maria Singh come amministratore in data 05 feb 2019

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name03 gen 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 20 dic 2018

    RES15

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    30 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Farnborough Business Park Pinehurst Road Farnborough GU14 7BF England a Farnborough Business Park 1 Pinehurst Road Farnborough Hampshire GU14 7BF in data 04 giu 2018

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Riverview the Meadows Business Park Station Approach Camberley Surrey GU17 9AB a Farnborough Business Park Pinehurst Road Farnborough GU14 7BF in data 30 mag 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Inc Research Holdings, Inc come persona con controllo significativo il 04 gen 2018

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Alistair John Macdonald il 01 ott 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    31 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONNELL, Kirstin Maura Mackenzie
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish121742610001
    MACDONALD, Alistair John
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish177452780002
    SINGH, Nyla Natalie Donna Maria
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152049680001
    COWAN, Desmond Joseph Paul Edward
    52 Leith Walk
    EH6 5HW Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    52 Leith Walk
    EH6 5HW Edinburgh
    Midlothian
    British83009100001
    FRENCH, Charlotte Ann
    Hudson Cottage
    Howsham
    YO6 7PH York
    North Yorkshire
    Segretario
    Hudson Cottage
    Howsham
    YO6 7PH York
    North Yorkshire
    British35214860001
    HARRISON, Leigh Gordon
    Peak House
    The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HZ Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    Peak House
    The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HZ Thatcham
    Berkshire
    British71250990001
    JOHST, David P
    7 Meadow View Lane
    Andover
    Massachusetts 01810
    U S A
    Segretario
    7 Meadow View Lane
    Andover
    Massachusetts 01810
    U S A
    American101051040001
    JONES, Angela Margaret
    The Beren Hatchgate Farm
    Cockpole Green Wargrave
    RG10 8NE Reading
    Berkshire
    Segretario
    The Beren Hatchgate Farm
    Cockpole Green Wargrave
    RG10 8NE Reading
    Berkshire
    British35510100002
    LESLIE, Stewart Gordon
    11 Walker Street
    EH3 7NE Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    11 Walker Street
    EH3 7NE Edinburgh
    Midlothian
    British66170500001
    MOORE, Douglas Frank
    Welham Hall
    Welham
    YO17 9QF Malton
    North Yorkshire
    Segretario
    Welham Hall
    Welham
    YO17 9QF Malton
    North Yorkshire
    British7282400001
    SAYERS, James Christopher
    5 Whitchurch Close
    SL6 7TZ Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    5 Whitchurch Close
    SL6 7TZ Maidenhead
    Berkshire
    British36434820001
    SHAW, William Lawson, Dr
    2 Autumn Walk
    SL6 4ND Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    2 Autumn Walk
    SL6 4ND Maidenhead
    Berkshire
    British48559390005
    SINGH, Nyla Natalie Donna Maria
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    1 Pinehurst Road
    GU14 7BF Farnborough
    Farnborough Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    British177453250001
    SINGH, Nyla Natalie
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    British53140790003
    WALL, Karen Malinda
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    British162650850001
    WILLIAMS, Nigel James, Dr
    Slievehamon
    Oakleigh Road Hatch End
    HA5 4HB Pinner
    Middlesex
    Segretario
    Slievehamon
    Oakleigh Road Hatch End
    HA5 4HB Pinner
    Middlesex
    British58705320001
    YENDELL, Timothy Patrick
    64 Donnington Gardens
    RG1 5LZ Reading
    Berkshire
    Segretario
    64 Donnington Gardens
    RG1 5LZ Reading
    Berkshire
    British64274200001
    ACKERMAN, Thomas Francis
    11 Athertone Circle
    Lynnfield
    Massachusetts 01940
    U S A
    Amministratore
    11 Athertone Circle
    Lynnfield
    Massachusetts 01940
    U S A
    AmericanUnited States101051180001
    BERGEN, Christopher
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    UsaUnited States62057130002
    BOYCE, Alan James
    Cambrian Close
    GU15 3LD Camberley
    35
    Surrey
    Amministratore
    Cambrian Close
    GU15 3LD Camberley
    35
    Surrey
    United KingdomBritish78141200001
    BRENKERT III, Karl
    981 Paxton Lake Drive
    Loveland
    Ohio 45140
    Usa
    Amministratore
    981 Paxton Lake Drive
    Loveland
    Ohio 45140
    Usa
    American86872650002
    CHEESMAN, Keith A
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    UsaUnited States138222390001
    COWAN, Desmond Joseph Paul Edward
    52 Leith Walk
    EH6 5HW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    52 Leith Walk
    EH6 5HW Edinburgh
    Midlothian
    British83009100001
    DE WITT, Jan, Dr
    Charlotte De Bourbonlaan
    3708 CD Zeist
    Holland
    Amministratore
    Charlotte De Bourbonlaan
    3708 CD Zeist
    Holland
    Dutch58705310001
    FOSTER, James Clifford
    16 Hancock Road
    Weston
    Massachusetts 02493
    U S A
    Amministratore
    16 Hancock Road
    Weston
    Massachusetts 02493
    U S A
    Usa101050900001
    GANLEY, John Leo
    Wedgefield Plantation
    Georgetown South Carolina 29440
    FOREIGN
    Usa
    Amministratore
    Wedgefield Plantation
    Georgetown South Carolina 29440
    FOREIGN
    Usa
    Us Citizen7518960001
    GILL, David Neil
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    UsaUnited States167395680001
    GOODMAN, Nigel
    52 Westover Road
    SW18 2RH London
    Amministratore
    52 Westover Road
    SW18 2RH London
    British60771380001
    HARRISON, Leigh Gordon
    Peak House
    The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HZ Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    Peak House
    The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HZ Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish71250990001
    JOHST, David P
    7 Meadow View Lane
    Andover
    Massachusetts 01810
    U S A
    Amministratore
    7 Meadow View Lane
    Andover
    Massachusetts 01810
    U S A
    AmericanAmerican101051040001
    JONES, Angela Margaret
    The Beren Hatchgate Farm
    Cockpole Green Wargrave
    RG10 8NE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Beren Hatchgate Farm
    Cockpole Green Wargrave
    RG10 8NE Reading
    Berkshire
    British35510100002
    KENDLE, Candace
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Meadows Business Park
    Station Approach
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United Kingdom
    UsaUnited States62038310002
    KERKHOF, Glenn Cornelis
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Netherlands99733300002
    KERKHOF, Glenn Cornelis
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Netherlands99733300002
    LESLIE, Stewart Gordon
    11 Walker Street
    EH3 7NE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    11 Walker Street
    EH3 7NE Edinburgh
    Midlothian
    British66170500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Syneos Health, Inc
    Silverside Road
    Tatnall Building #104
    Wilmington
    3411
    De 19810
    United States
    06 apr 2016
    Silverside Road
    Tatnall Building #104
    Wilmington
    3411
    De 19810
    United States
    No
    Forma giuridicaCorporation
    Paese di registrazioneDelaware, Usa
    Autorità legaleGeneral Corporation Law Of The State Of Delaware, Usa
    Luogo di registrazioneDelaware Secretary Of State'S Office
    Numero di registrazione4858554
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SYNEOS HEALTH CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 18 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to one or more lenders or their respective affiliates on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures & equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank N.A.
    Transazioni
    • 18 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 ago 2006
    Consegnato il 05 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower and the other loan parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag, Stamford Branch (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 05 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A collateral agreement
    Creato il 30 lug 2003
    Consegnato il 16 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers or any of their subsidiaries to the lenders or the agents under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the following property now owned or at any time acquired by the grantor after the date of the collateral agreement, all accounts all cash and currency all chattel paper all commercial tort claims all deposit accounts all documents all equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank National Association
    Transazioni
    • 16 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2003
    Consegnato il 16 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank, National Association as Security Trustee
    Transazioni
    • 16 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 giu 2002
    Consegnato il 10 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 10 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0