JCB FINANCE (LEASING) LTD

JCB FINANCE (LEASING) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJCB FINANCE (LEASING) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02211998
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JCB CREDIT (LEASING) LIMITED06 apr 198806 apr 1988
    TABSHIRE LIMITED20 gen 198820 gen 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 08 dic 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Joseph Alexander Pattara come amministratore in data 13 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian John Isaac come amministratore in data 13 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Ronald Jennings come amministratore in data 13 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Thomas Brown come amministratore in data 13 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Charles Hall come amministratore in data 13 set 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gary Stephen Mcginty come amministratore in data 13 set 2021

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2020 al 30 giu 2021

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Alexander Pattara il 27 lug 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Alexander Pattara il 27 lug 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Alexander Pattara il 27 lug 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian John Isaac il 27 lug 2021

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Gary Stephen Mcginty come amministratore in data 01 apr 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David George Powell come amministratore in data 31 mar 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    20 pagineAA

    Nomina di Mr David Thomas Brown come amministratore in data 03 lug 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HELDREICH, Robert John
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    Jcb Finance Ltd The Mill
    Staffordshire
    England
    Segretario
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    Jcb Finance Ltd The Mill
    Staffordshire
    England
    183123000001
    HELDREICH, Robert John
    c/o Jcb Finance Ltd
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    The Mill
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    c/o Jcb Finance Ltd
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    The Mill
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish179208550001
    WINTER, Robert Alexander Mark
    Lakeside Works
    ST14 5JP Rocester
    J C Bamford Excavators Ltd
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Lakeside Works
    ST14 5JP Rocester
    J C Bamford Excavators Ltd
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish269975170001
    WORKMAN, John Donald Black
    1st Floor, 440 Strand
    WC2R 0QS London
    Coutts & Co
    England
    Amministratore
    1st Floor, 440 Strand
    WC2R 0QS London
    Coutts & Co
    England
    ScotlandBritish78893620002
    HALL, Jonathan Charles
    Tunnicliffe Way
    ST14 5NP Uttoxeter
    12
    Staffordshire
    Segretario
    Tunnicliffe Way
    ST14 5NP Uttoxeter
    12
    Staffordshire
    British126210900001
    SNELSON, Peter Johannus
    Jade Cottage
    Hollington
    ST10 4HH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Jade Cottage
    Hollington
    ST10 4HH Stoke On Trent
    Staffordshire
    British193504170001
    BALDOCK, Alexander David
    Wallingford Avenue
    W10 6QB London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Wallingford Avenue
    W10 6QB London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish132330380001
    BAMFORD, Anthony Paul, Lord
    Daylesford House
    GL56 0YH Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Daylesford House
    GL56 0YH Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    EnglandBritish149583220001
    BAMFORD, Joseph Cyril Edward
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    Amministratore
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    EnglandBritish113106310003
    BARNARD, Andrew David
    Bell Road
    Warnham
    RH12 3QL Horsham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Bell Road
    Warnham
    RH12 3QL Horsham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritish137736080001
    BROWN, David Thomas
    Lakeside Works
    Rocester
    ST14 5JP Uttoxeter
    J C Bamford Excavators Ltd
    England
    Amministratore
    Lakeside Works
    Rocester
    ST14 5JP Uttoxeter
    J C Bamford Excavators Ltd
    England
    EnglandBritish175821970001
    BURGESS, David John
    Ullenhall Lane Cottage
    Ullenhall Lane
    B98 9ES Beoley
    Worcs
    Amministratore
    Ullenhall Lane Cottage
    Ullenhall Lane
    B98 9ES Beoley
    Worcs
    United KingdomBritish6269310002
    DOLBEAR, David Samuel
    Lakeside Works
    Rocester
    ST14 5JP Uttoxeter
    Jc Bamford Excavators Ltd
    England
    Amministratore
    Lakeside Works
    Rocester
    ST14 5JP Uttoxeter
    Jc Bamford Excavators Ltd
    England
    EnglandBritish173244670001
    GADSBY, Andrew Paul
    123 High Street
    RH10 1DD Crawley
    Floor 3, Turnpike House
    Surrey
    England
    Amministratore
    123 High Street
    RH10 1DD Crawley
    Floor 3, Turnpike House
    Surrey
    England
    EnglandBritish74834980002
    GORDON, Alan John
    11 Church Avenue
    BT37 0PJ Newtownabbey
    County Antrim
    Amministratore
    11 Church Avenue
    BT37 0PJ Newtownabbey
    County Antrim
    Northern IrelandBritish3940380001
    GREEN, Gordon Bewick
    229 Eccleshall Road
    ST16 1PE Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    229 Eccleshall Road
    ST16 1PE Stafford
    Staffordshire
    British55870430001
    HALL, Jonathan Charles
    Tunnicliffe Way
    ST14 5NP Uttoxeter
    12
    Staffordshire
    Amministratore
    Tunnicliffe Way
    ST14 5NP Uttoxeter
    12
    Staffordshire
    EnglandBritish126210900001
    HARGREAVES, Michael
    Northesk Lodge
    16 Northesk Street
    ST15 8EP Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    Northesk Lodge
    16 Northesk Street
    ST15 8EP Stone
    Staffordshire
    EnglandBritish81632010002
    HART, Andrew Stuart
    31 Daws Lea
    HP11 1QG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Daws Lea
    HP11 1QG High Wycombe
    Buckinghamshire
    UkBritish122344060001
    HEMSLEY, Richard Andrew
    c/o The Royal Bank Of Scotland Plc
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    Great Britain
    Amministratore
    c/o The Royal Bank Of Scotland Plc
    Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    280
    Great Britain
    United KingdomBritish183253160001
    ISAAC, Ian John
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    Lombard
    England
    Amministratore
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    Lombard
    England
    EnglandBritish195554680001
    JENNINGS, Paul Ronald
    Commonside
    Boundary
    ST10 2NU Cheadle
    Thorn Cottage
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Commonside
    Boundary
    ST10 2NU Cheadle
    Thorn Cottage
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish163624150001
    JOHNSTON, Gilbert
    26 Church Road
    Rolleston On Dove
    DE13 9BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    26 Church Road
    Rolleston On Dove
    DE13 9BE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish17488390001
    KELLS, Ronald David
    The Moyle 10 Upper Knockbreda Road
    BT6 9QA Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    The Moyle 10 Upper Knockbreda Road
    BT6 9QA Belfast
    County Antrim
    United KingdomBritish145708540001
    KINGSTON, William Bernard
    15 Granville Road
    Black Rock
    IRISH Co Dublin
    Eire
    Amministratore
    15 Granville Road
    Black Rock
    IRISH Co Dublin
    Eire
    Irish66204500002
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    British67501900002
    LEADBEATER, Edward Timothy David
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    British34775550001
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    Amministratore
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrish100755360001
    MARROW, Paul
    c/o Jcb Finance Ltd
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    The Mill
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    c/o Jcb Finance Ltd
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    The Mill
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritish85771600001
    MARSTON, Paul Martin
    8 Heritage View
    Hatch Warren
    RG22 4XN Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    8 Heritage View
    Hatch Warren
    RG22 4XN Basingstoke
    Hampshire
    British106148100001
    MCGINTY, Gary Stephen
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    Amministratore
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    EnglandBritish281603520001
    MCKAY, Robert John
    2 Ballyrussell Road
    Dundonald
    BT16 1XE Belfast
    Amministratore
    2 Ballyrussell Road
    Dundonald
    BT16 1XE Belfast
    Northern IrelandIrish143980140002
    PATTARA, Joseph Alexander
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    Natwest Group
    England
    Amministratore
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    Natwest Group
    England
    EnglandBritish218232410001
    PEARSON, William
    49 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    49 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritish93958270001
    POWELL, David George
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    Amministratore
    The Mill
    High Street
    ST14 5JW Rocester
    Staffs
    EnglandBritish174976000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JCB FINANCE (LEASING) LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Jcb Finance Ltd
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    The Mill
    England
    06 apr 2016
    High Street
    Rocester
    ST14 5JW Uttoxeter
    The Mill
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Comapnies Registry
    Numero di registrazione972265
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0