GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED

GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02212509
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    • fabbricazione di altri contenitori in carta e cartone (17219) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STANDTYPE LIMITED21 gen 198821 gen 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2020

    21 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    24 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    16 pagineAM02

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    49 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Pullman House Treefield Industrial Estate Gelderd Road Leeds LS27 7JU a Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ in data 16 feb 2018

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 apr 2017

    20 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    1 pagineMR04

    Notifica di John Eric Rose come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di Barry Frank Williamson come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di Ian Roger Mitchelson come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di Warren Bruce Shermer come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2016

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 lug 2016

    Stato del capitale al 26 lug 2016

    • Capitale: GBP 120,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 022125090021 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHERMER, Warren Bruce
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    Segretario
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    BritishManging Director90009410002
    MITCHELSON, Ian Roger
    Pemberley Court
    Ripponden
    HX6 4JF Sowerby Bridge
    4
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Pemberley Court
    Ripponden
    HX6 4JF Sowerby Bridge
    4
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSales Director105776290002
    ROSE, John Eric
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    Amministratore
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    EnglandBritishDirector152833810001
    SHERMER, Warren Bruce
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    Amministratore
    Walton Park
    Pannal
    HG3 1EJ Harrogate
    68
    England
    EnglandBritishManaging Director90009410002
    WILLIAMSON, Barry Frank
    Apartment 5 Buckley House
    Lancaster Road
    M20 2QU Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    Apartment 5 Buckley House
    Lancaster Road
    M20 2QU Manchester
    Greater Manchester
    EnglandBritishDirector105787550002
    BASNETT, Robert William
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Director105776210001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Segretario
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrishCompany Director54812330001
    GILL, Jane
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    Segretario
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    British12519680001
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    65475060002
    BASNETT, Robert William
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Chadwick Lane
    Lower Hopton
    WF14 8RA Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director105776210001
    CARTLIDGE, Donald William
    14 Rievaulx Close
    HG5 8NG Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    14 Rievaulx Close
    HG5 8NG Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishDirector54001690002
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Amministratore
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishCompany Director54812330001
    CROISDALE, John Russell
    27 Lightridge Road
    Fixby
    HD2 2HE Huddersfield
    Amministratore
    27 Lightridge Road
    Fixby
    HD2 2HE Huddersfield
    BritishDirector48813710002
    CROISDALE, John Russell
    47 Tofts Grove
    Rastrick
    HD6 3XG Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    47 Tofts Grove
    Rastrick
    HD6 3XG Brighouse
    West Yorkshire
    BritishDirector48813710001
    GILL, Anthony Stephen
    Angel House Church Street
    Kirk Hammerton
    YO26 8DD York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Angel House Church Street
    Kirk Hammerton
    YO26 8DD York
    North Yorkshire
    EnglandEnglishCompany Director57831700001
    GILL, Jane
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Coach House
    Westfield Road Tockwith
    YO5 8PY York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director12519680001
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishCompany Director78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant96288470001
    MULLER, Philip Harvey
    71 Oakdale
    HG1 2LT Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    71 Oakdale
    HG1 2LT Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector75652830001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    PENNIE, Richard Kevin
    20 Vinery Close
    Clayton West
    HD8 9XH Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    20 Vinery Close
    Clayton West
    HD8 9XH Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishKey Accounts Director105963010001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Barry Frank Williamson
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06 apr 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Warren Bruce Shermer
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06 apr 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Ian Roger Mitchelson
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06 apr 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr John Eric Rose
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    06 apr 2016
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Toronto Square
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 giu 2016
    Consegnato il 10 giu 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 10 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 giu 2016
    Consegnato il 10 giu 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 10 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2013
    Consegnato il 21 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 dic 2011
    Consegnato il 23 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chattels being 5 colour offset printing press with: sheet feeder, max sheet size 820MM x 1130MM 5 printing heads coating head ir dryer shhet stacket s/n 157 (for details of further chattels charged please refer to form MG01) including all engines, appliances, parts, spare parts, components, instruments, appurtenances, accessories and other equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 dic 2011
    Consegnato il 22 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 ago 2006
    Consegnato il 22 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Winkler & dunnebier - refurbished high speed envelope machine serial no. 10.674.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 22 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 14 giu 2006
    Consegnato il 22 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Winkler & dunnebier - envelope makeing machine - s/no: 15608.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 nov 2005
    Consegnato il 05 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Halm two colour envelope printing press s/no SJP7142.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 05 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 21 set 2005
    Consegnato il 29 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Winkler & dunnebier-high speed envelope machine-s/n 11.146.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 29 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 24 ago 2005
    Consegnato il 02 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Halm web offset printer/feeder/cylinders/water system/delivery table/counter/dryer/cooling unit s/no EM57120.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 02 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the baring english growth fund (north) LP, baring english growth fund (south) LP or the chargee (together the beneficiaries) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit d, treefield industrial estate, gelderd road, gildersome, leeds, LS27 7JU;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bpep Management (UK) Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 25 mag 2005
    Consegnato il 28 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Model lithrome l-44 s/n 157 description 44" five colour press with coaster, 68886.315 million imps including the chattels shown on the additional asset list to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 28 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 mag 2005
    Consegnato il 28 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 28 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 08 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transazioni
    • 08 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 1996
    Consegnato il 09 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC in Its Capacity as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 06 giu 1995
    Consegnato il 13 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 apr 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the debts and the benefit of all securities and guarantees for the same and all interest (if any) due or which becomes due in respect thereof by way of specific equitable charge all the equitably charged property (other than the f/h's at maserati house gelderd road leeds and ingram road holbeck leeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 nov 1994
    Consegnato il 22 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the north west side of ingram road holbeck leeds west yorkshire t/n wyk 556729 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1992
    Consegnato il 10 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north west side of gelderd road leeds west yorkshire t/n ywe 13880 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 nov 1989
    Consegnato il 13 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 mag 1988
    Consegnato il 24 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 121E whitehall estate leeds. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GREAT NORTHERN ENVELOPE COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 feb 2018Inizio dell'amministrazione
    16 ago 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Edward Reed
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    2
    DataTipo
    16 ago 2019Inizio della liquidazione
    11 apr 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Edward Reed
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Nicholas Edward Reed
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Fourth Floor Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0