TRIBAL ADVERTISING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRIBAL ADVERTISING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02214955 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Kings Orchard Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MUSTOES LIMITED | 10 dic 2002 | 10 dic 2002 |
| MUSTOE MERRIMAN LEVY LIMITED | 22 giu 2001 | 22 giu 2001 |
| MUSTOE MERRIMAN HERRING LEVY LIMITED | 03 set 1993 | 03 set 1993 |
| ADDITION MARKETING LIMITED | 02 ago 1988 | 02 ago 1988 |
| BEALAW (208) LIMITED | 28 gen 1988 | 28 gen 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Stato del capitale al 28 gen 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Robert Charles Garner come amministratore in data 01 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Keith Martin Evans come amministratore in data 30 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derrick Breach il 05 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ in data 04 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 87-91 Newman Street London W1T 3EY United Kingdom* in data 09 mar 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Lorraine Davis come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Dr Keith Martin Evans come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Martin come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRIBAL ADVERTISING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREACH, Stephen Derrick | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 174695940001 | |||||
| GARNER, Robert Charles | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | United Kingdom | British | 53391420003 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Segretario | Newman Street W1T 3EY London 87-91 United Kingdom | British | 53398040001 | ||||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Segretario | Newman Street W1T 3EY London 87-91 United Kingdom | 150580820001 | |||||||
| DSOUZA, Sevellon | Segretario | 24 Gloucester Circus SE10 8RY London | British | 13570330001 | ||||||
| JACKSON, Ingrid | Segretario | 1 Woodbine Lane BN8 4LH Newick East Sussex | British | 39821430001 | ||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002710001 | |||||||
| HEXAGON REGISTRARS LIMITED | Segretario | Ten Dominion Street EC2M 2EE London | 4004080002 | |||||||
| AMADEO, Andrew | Amministratore | 148 Weston Park N8 9PN London | British | 79817990001 | ||||||
| CLARK, Nigel Culliford | Amministratore | 10 Weltje Road W6 4TJ London | British | 15454020001 | ||||||
| DIVER, William Paul | Amministratore | Flat 4 2 Kempsford Gardens SW5 9LH London | United Kingdom | British | 68328530001 | |||||
| DSOUZA, Sevellon | Amministratore | 24 Gloucester Circus SE10 8RY London | British | 13570330001 | ||||||
| EVANS, Keith Martin, Dr | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | United Kingdom | British | 159812510001 | |||||
| FAIR, Howard | Amministratore | 29 Canons Close WD7 7ER Radlett Hertfordshire | British | 75764390001 | ||||||
| FIELD, Andrew | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 United Kingdom | England | British | 61471170001 | |||||
| HARDING, Matthew | Amministratore | 55 Corbyn Street N4 3BY London | British | 41428120004 | ||||||
| HERRING, Christopher | Amministratore | 54 Chestnut Avenue KT10 8JF Esher Surrey | British | 39820940002 | ||||||
| HORNER, Damian | Amministratore | Flat 170c Walm Lane Willesden Green NW2 3AX London | British | 87850780001 | ||||||
| JACKSON, Ingrid | Amministratore | 1 Woodbine Lane BN8 4LH Newick East Sussex | British | 39821430001 | ||||||
| JACKSON, Ingrid | Amministratore | 1 Woodbine Lane BN8 4LH Newick East Sussex | British | 39821430001 | ||||||
| JITSUKAWA, Haruhiko | Amministratore | 3-7-13 Nishigaoka Izumi-Ku Yokohama-Shi Kanagawa Japan | Japanese | 77517640001 | ||||||
| KATO, Toshiaki | Amministratore | Chu 2-42-12-103 Nakano-Ku FOREIGN Tokyo Japan | Japan | Japanese | 151039390001 | |||||
| KATSUI, Ryoichi | Amministratore | Flat 14 Cresta House 133 Finchley Road NW3 6HT London | Japanese | 66326810003 | ||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 United Kingdom | England | British | 68807890004 | |||||
| LEVY, Andrew Paul | Amministratore | Brambles Common Lane WD4 9HP Kings Langley Hertfordshire | England | British | 57420490002 | |||||
| LEVY, Andrew Paul | Amministratore | Brambles Common Lane WD4 9HP Kings Langley Hertfordshire | England | British | 57420490002 | |||||
| MAHONEY, Michael | Amministratore | 11 Althorpe Road Wandsworth SW17 London | British | 102797480001 | ||||||
| MAHONEY, Michael | Amministratore | 11 Althorpe Road Wandsworth SW17 London | British | 102797480001 | ||||||
| MAHONEY, Michael | Amministratore | 11 Althorpe Road Wandsworth SW17 London | British | 102797480001 | ||||||
| MARTIN, Peter John | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 United Kingdom | England | British | 176044430001 | |||||
| MATSUMOTO, Shu | Amministratore | 2-5-5-1202 Yushima Bunkyo-Ku Tokyo Japan | Japanese | 86746990001 | ||||||
| MCTAVISH, Douglas Gilchrist | Amministratore | 15 Moneyhill Road WD3 2EG Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 178889810001 | |||||
| MERRIMAN, John | Amministratore | 35 Clovelly Road Ealing W5 5HF London | British | 39820750003 | ||||||
| MIYAZAKI, Yasuhisa | Amministratore | Tamako-Cho 1-1-75 FOREIGN Higashi Murayama Gty Tokyo Japan | Japanese | 112054100001 | ||||||
| MORRICE, Alan Forbes | Amministratore | Flat 1 6 Kings Avenue SW4 8BD London | British | 63090100001 |
TRIBAL ADVERTISING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 04 nov 2002 Consegnato il 13 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a 2 and 4 bucknall street 12 dyott street and part of castlewood house 77 to 91 (odd) new oxford street london borough of camden t/n 392196. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 01 ott 1999 Acquisito il 20 dic 2000 Consegnato il 22 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari F/H property k/a 12 dyott st london WC1A 1DF t/no 392196. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 ott 1999 Consegnato il 05 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 18 ago 1993 Consegnato il 25 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 23 set 1988 Consegnato il 29 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0