CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED

CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02216450
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    • (7020) /
    • (7032) /

    Dove si trova CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al20 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 ago 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mar 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 set 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mar 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 set 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 set 2008

    5 pagine4.68

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 20 mar 2007

    6 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 20 mar 2006

    7 pagineAA

    Varie

    O/C - replacement of liquidator
    8 pagineMISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Varie

    C/O replacement of liquidator
    8 pagineMISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine225

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    7 pagine4.68

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Chi sono gli amministratori di CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AITCHISON, Michael Anthony
    2 Buckstone Garth
    BD20 5JE East Morton
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Buckstone Garth
    BD20 5JE East Morton
    West Yorkshire
    British52389080001
    GILMAN, Christopher Edward
    253 High Street
    LS23 6AL Boston Spa
    West Yorkshire
    Amministratore
    253 High Street
    LS23 6AL Boston Spa
    West Yorkshire
    EnglandBritish79587880005
    MORTON, Kenneth
    Finwood
    College Farm Lane Linton
    LS22 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Finwood
    College Farm Lane Linton
    LS22 4HR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish118089230001
    MORTON, Richard John
    Riverside
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Leeds
    Amministratore
    Riverside
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Leeds
    United KingdomBritish72224050016
    MORTON, Toby James
    16 Albion Street
    LS23 6HY Clifford
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Albion Street
    LS23 6HY Clifford
    West Yorkshire
    EnglandBritish76028330001
    MORTON, Patricia Ann
    Crow Hill
    Crow Hill Lane, High Birstwith
    HG3 2LG Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Crow Hill
    Crow Hill Lane, High Birstwith
    HG3 2LG Harrogate
    North Yorkshire
    British31261180003
    BUCK, David Michael
    41 Thornbury Court
    36-38 Chepstow Villas
    W11 2RE London
    Amministratore
    41 Thornbury Court
    36-38 Chepstow Villas
    W11 2RE London
    British94879980001
    MORTON, Patricia Ann
    Crow Hill
    Crow Hill Lane, High Birstwith
    HG3 2LG Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crow Hill
    Crow Hill Lane, High Birstwith
    HG3 2LG Harrogate
    North Yorkshire
    British31261180003

    CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as north block (17 to 23) market street 1 to 9 charles street 35 to 45 broadway 13 and 15 cheapside bradford west yorkshire t/no: WYK430892. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a ivebridge house telephone house & thornton house market street bradford.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 19 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings k/a brigade house kirkstall road leeds west yorkshire t/n WYK562370, the f/h property l/a 14, 16 and 18A market place hyde tameside greater manchester t/n GM662672, the f/h property k/a land on the south east side of nepshaw lane leeds west yorkshire t/n WYK32111 (for details of further properties charged please refer to form 395). and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1996
    Acquisito il 11 ago 1997
    Consegnato il 25 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south east side of nepshaw lane and buildings on the north west side of nepshaw lane and land and buildings at nepshaw lane morley leeds west yorkshire t/n's WYK233550, WYK32111 and WYK507485.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 25 nov 1997Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1996
    Acquisito il 11 ago 1997
    Consegnato il 25 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    14, 16, 18 and 18A market place hyde tameside greater manchester t/n GM662672.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 25 nov 1997Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 dic 1996
    Consegnato il 23 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land on the north west side of abbey street (known as brigade house kirkstall road leeds) and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery the goodwill of any business the benefit of all licences all bookdebts and other debts and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 23 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 07 set 1992
    Consegnato il 17 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    100 wellington street leeds t/n wyk 350883 together with the benefit of a rental guarantee agreement contained in an agreement dated 2/11/90 and all property k/a castle house, castle street, leeds t/n wyk 453468 together with the benefit of a deed dated 070992 relating to 80 car parking spaces in the westgate multi-storey car park.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 17 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 1991
    Consegnato il 14 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    All sums from time to time standing to the credit of the cash security account referred to in the legal charge.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transazioni
    • 14 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 1991
    Consegnato il 06 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    All sums from time to time standing to the credit of castle house investments limited cash security account as is more particularly described in the legal charge dated 29TH november 1991.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Corporation (Funding) Limited
    Transazioni
    • 06 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 14 nov 1990
    Consegnato il 19 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    100 wellington street leeds t/n wyk 350883 fixed charge over the benefit of the personal covenants by the tenants and the guarantees in respect of such obligations in respect of the occupational leases of the property (please see doc for details).
    Persone aventi diritto
    • Ige Capital Corporation (Funding) Limited.
    Transazioni
    • 19 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 09 ott 1989
    Consegnato il 12 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a: castle house castle street leeds. See doc for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ige Capital Corporation (Funding) Limited
    Transazioni
    • 12 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CASTLE HOUSE INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2010Data di scioglimento
    20 mar 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Toby Scott Underwood
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Charles Macmillan
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0