COPTHORNE PROPERTIES LIMITED

COPTHORNE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOPTHORNE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02216771
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARA PROPERTIES LIMITED28 mar 198828 mar 1988
    MINMAR (36) LIMITED03 feb 198803 feb 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan Scott come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathon Grech come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2013

    Stato del capitale al 08 mag 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Nomina di Mr Alan George Scott come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Adrian Bushnell come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Nomina di Clive Anthony Harrington come amministratore

    3 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Copthorne Hotels Limited il 21 apr 2010

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Copthorne Hotels Limited il 21 apr 2010

    2 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Adrian John Bushnell il 26 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COPTHORNE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COPTHORNE HOTELS LIMITED
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Victoria House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Victoria House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00759611
    96328930001
    GRECH, Jonathon Mackenzie
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    Amministratore
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    United KingdomBritish181897650001
    HARRINGTON, Clive Anthony
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    Amministratore
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    United KingdomBritish157250790001
    COPTHORNE HOTELS LIMITED
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Victoria House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Victoria House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00759611
    96328930001
    HANCOCK COOK, David Alan
    Hillside Hillydeal Road
    Otford
    TN14 5RT Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Hillside Hillydeal Road
    Otford
    TN14 5RT Sevenoaks
    Kent
    British29033120002
    HODGES, Simon
    Lauree Lee
    Haglands Lane, West Chiltington
    RH20 2QR Pulborough
    West Sussex
    Segretario
    Lauree Lee
    Haglands Lane, West Chiltington
    RH20 2QR Pulborough
    West Sussex
    British66090970003
    SELWYN, Julian
    3 Headley Close
    West Ewell
    KT19 9JA Epsom
    Surrey
    Segretario
    3 Headley Close
    West Ewell
    KT19 9JA Epsom
    Surrey
    British17394580002
    THOMAS, David Fraser
    Glendevon 9 Cheyne Walk
    CR0 7HH Croydon
    Surrey
    Segretario
    Glendevon 9 Cheyne Walk
    CR0 7HH Croydon
    Surrey
    British27763020002
    BROWN, Frederick James Arthur
    Little Nearton 2 Nether Lane
    Flore
    NN7 4LR Northampton
    Amministratore
    Little Nearton 2 Nether Lane
    Flore
    NN7 4LR Northampton
    British45269280001
    BUSHNELL, Adrian John
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    Amministratore
    Victoria House
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Surrey
    United KingdomBritish210900670001
    HANCOCK COOK, David Alan
    Hillside Hillydeal Road
    Otford
    TN14 5RT Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Hillside Hillydeal Road
    Otford
    TN14 5RT Sevenoaks
    Kent
    British29033120002
    JACKSON, David
    141 Argyle Road
    Ealing
    W13 8ER London
    Amministratore
    141 Argyle Road
    Ealing
    W13 8ER London
    United KingdomBritish2147720001
    POTTER, Anthony Grahame
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British62316310001
    SCOTT, Alan George, Mr.
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Victoria House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Road
    RH6 7AF Horley
    Victoria House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish15259430001
    SELWYN, Julian
    23 Cypress Court
    SM1 2SU Sutton
    Surrey
    Amministratore
    23 Cypress Court
    SM1 2SU Sutton
    Surrey
    British17394580001
    TAYLOR, Peter James
    Brooklands Dale Road
    RH18 5BP Forest Row
    East Sussex
    Amministratore
    Brooklands Dale Road
    RH18 5BP Forest Row
    East Sussex
    British2317180001
    THOMAS, David Fraser
    Glendevon 9 Cheyne Walk
    CR0 7HH Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Glendevon 9 Cheyne Walk
    CR0 7HH Croydon
    Surrey
    British27763020002
    WHEATLEY, Brian Joseph
    42 Ardeevan Avenue
    IRISH Lucan
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    42 Ardeevan Avenue
    IRISH Lucan
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish45018790001

    COPTHORNE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third party trust debenture
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moniews due or to become due from the company and/or london tara hotel limited to the chargee under the terms of the loan agreement (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    1). f/h property k/a the london tara hotel scarsdale place kensington W8 london borough of kensington and chelsea. T/n 154810 2). l/h property at the london tara hotel aforesaid. T/n NGL246441. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust debenture
    Creato il 29 mar 1988
    Consegnato il 18 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to natwest investment bank limited under the terms of a loan agreement (as defined) and this charge
    Brevi particolari
    F/H land lying to the east of scarsdale place, yensington in tn ngl 154810, together with all fixtures & fittings & fixed plant & machinery from time to time owned by the company first fixed charge all the present & future goodwill of the company floating charge all the undertaking and all the property and assets of the company both present & future not otherwise effectively mortgaged or charged by the trust debenture (see from 395 for further details.).
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 18 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0