CSC PROPERTIES 2021 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CSC PROPERTIES 2021 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02218116 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
- (4521) /
Dove si trova CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 40 Broadway London Sw1h 0bu |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| C&C PROPERTIES 2021 LIMITED | 11 dic 2001 | 11 dic 2001 |
| BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (BROMLEY) LIMITED | 31 mar 1988 | 31 mar 1988 |
| MODERNTWIN LIMITED | 05 feb 1988 | 05 feb 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Susan Folger il 04 giu 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Kildea come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Kay Elizabeth Chaldecott il 13 ago 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Edward Matthew Giles Roberts come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Kay Elizabeth Chaldecott come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mark Kildea come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Gary Richard Hoskins come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Caroline Kirby come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Yardley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Balbinder Tattar come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Hawksworth come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed c&c properties 2021 LIMITED\certificate issued on 21/05/10 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gary James Yardley il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Balbinder Singh Tattar il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ian David Hawksworth il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Andrew Fischel il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Susan Folger il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSDEN, Susan | Segretario | Broadway SW1H 0BU London 40 | British | 68599110004 | ||||||
| CHALDECOTT, Kay Elizabeth | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | England | British | 68694110002 | |||||
| FISCHEL, David Andrew | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 8845220002 | |||||
| HOSKINS, Gary Richard | Amministratore | Broadway SW1H 0BT London 40 | United Kingdom | British | 153902440001 | |||||
| KIRBY, Caroline | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | England | British | 108375400001 | |||||
| ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 154029500001 | |||||
| BOTTLE, Jeremy Stephen | Segretario | 39 Farnaby Road Shortlands BR1 4BL Bromley Kent | British | 14465210001 | ||||||
| ABEL, John George | Amministratore | 9 Hutton Gate Hutton Mount CM13 2XA Brentwood Essex | Uk | British | 14465220002 | |||||
| BLACK, William Reginald | Amministratore | Marley Side Marley Heights Kingsley Green GU27 3LU Haslemere Surrey | England | British | 41017610002 | |||||
| HAWKSWORTH, Ian David | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 115713550001 | |||||
| JOLLY, Brian Anthony | Amministratore | 14 Links Road KT17 3PS Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14465250001 | |||||
| KILDEA, Mark | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 89161850003 | |||||
| MARCUCCILLI, Gary John | Amministratore | 29 Manor Wood Road CR8 4LG Purley Surrey | United Kingdom | British | 65438590002 | |||||
| SAGGERS, John Ian | Amministratore | Galleon House Martlesham Road Little Bealings IP13 6LX Woodbridge Suffolk | British | 35538650002 | ||||||
| SMITH, Aidan Christopher | Amministratore | 50 Wavendon Avenue Chiswick W4 4NS London | United Kingdom | British | 31140320001 | |||||
| TATTAR, Balbinder Singh | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 105287960002 | |||||
| YARDLEY, Gary James | Amministratore | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 55671660002 |
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Trust deed | Creato il 05 ott 2006 Consegnato il 06 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £354,876,000 5.562 per cent. First mortgage debenture stock 2027 of capital & counties debenture PLC and all other moneys under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n sf 358502 l/h marland house 26-29 sloane street and 43-47 (odd numbers) pavillion road kensington london t/n LN216478 * for details of further property charged please refer to form 395 *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 17 feb 2006 Consegnato il 22 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari F/H property k/a queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n SF358502. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First supplemental trust deed | Creato il 03 set 2002 Consegnato il 04 set 2002 | In corso | Importo garantito The principal of £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All monies payable by virtue of any insurances on the mortgaged premises,as defined in the principal deed,pursuant to clauses 17(m) and 17(n) of the principal trust deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 15 ott 2001 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/Hold property being dudley house,169 piccadilly,london W1; ngl 804655. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 04 mag 2000 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari F/Hold property being 32 and 33 long acre,london WC2; NGL775393. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 21 mag 1998 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/Hold property being 12 and 14 new fetter lane,london EC4; NGL573821. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 21 mag 1998 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/Hold property being carrington house,126,128 and 130 regent st,4 regent place and 36,38 and 40 warwick st,london W1; ngl 530323. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 02 giu 1997 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 11 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/H commonwealth house hammersmith london t/no NGL385177. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance and release | Creato il 06 ott 1994 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari F/Hold property being capital place,bath rd,harlington; agl 443. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance and release | Creato il 06 ott 1994 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/Hold property being walmar house,288-300 (even) regent st,15-16 great castle st,45-46 margaret st,london W1; t/no ngl 440302. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 14 mar 1991 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | In corso | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/Hold property being 190 strand,194 strand,2-8 maltravers st,canberra house,10-16 maltravers st,18-24 maltravers st,1 maltravers street and 7 arundel st,strand,london WC2; t/no NGL32297. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 14 mar 1991 Acquisito il 03 set 2002 Consegnato il 24 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari L/Hold property being marland house,26-29 sloane street and 43-47 (odd nos) pavillion rd,london SW1; t/no LN216478. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0