CSC PROPERTIES 2021 LIMITED

CSC PROPERTIES 2021 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCSC PROPERTIES 2021 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02218116
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    40 Broadway
    London
    Sw1h 0bu
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    C&C PROPERTIES 2021 LIMITED11 dic 200111 dic 2001
    BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (BROMLEY) LIMITED31 mar 198831 mar 1988
    MODERNTWIN LIMITED05 feb 198805 feb 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del segretario cambiati per Susan Folger il 04 giu 2011

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagineMG02

    Cessazione della carica di Mark Kildea come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mag 2011

    Stato del capitale al 24 mag 2011

    • Capitale: GBP 250
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kay Elizabeth Chaldecott il 13 ago 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    11 pagineAA

    Nomina di Edward Matthew Giles Roberts come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Kay Elizabeth Chaldecott come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mark Kildea come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Gary Richard Hoskins come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Caroline Kirby come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gary Yardley come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Balbinder Tattar come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Hawksworth come amministratore

    1 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed c&c properties 2021 LIMITED\certificate issued on 21/05/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 mag 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dettagli del direttore cambiati per Gary James Yardley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Balbinder Singh Tattar il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian David Hawksworth il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Andrew Fischel il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Susan Folger il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di CSC PROPERTIES 2021 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARSDEN, Susan
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Segretario
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    British68599110004
    CHALDECOTT, Kay Elizabeth
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    EnglandBritish68694110002
    FISCHEL, David Andrew
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish8845220002
    HOSKINS, Gary Richard
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    United KingdomBritish153902440001
    KIRBY, Caroline
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    EnglandBritish108375400001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish154029500001
    BOTTLE, Jeremy Stephen
    39 Farnaby Road
    Shortlands
    BR1 4BL Bromley
    Kent
    Segretario
    39 Farnaby Road
    Shortlands
    BR1 4BL Bromley
    Kent
    British14465210001
    ABEL, John George
    9 Hutton Gate
    Hutton Mount
    CM13 2XA Brentwood
    Essex
    Amministratore
    9 Hutton Gate
    Hutton Mount
    CM13 2XA Brentwood
    Essex
    UkBritish14465220002
    BLACK, William Reginald
    Marley Side Marley Heights
    Kingsley Green
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Marley Side Marley Heights
    Kingsley Green
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish41017610002
    HAWKSWORTH, Ian David
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish115713550001
    JOLLY, Brian Anthony
    14 Links Road
    KT17 3PS Epsom
    Surrey
    Amministratore
    14 Links Road
    KT17 3PS Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish14465250001
    KILDEA, Mark
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish89161850003
    MARCUCCILLI, Gary John
    29 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Amministratore
    29 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritish65438590002
    SAGGERS, John Ian
    Galleon House
    Martlesham Road Little Bealings
    IP13 6LX Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Galleon House
    Martlesham Road Little Bealings
    IP13 6LX Woodbridge
    Suffolk
    British35538650002
    SMITH, Aidan Christopher
    50 Wavendon Avenue
    Chiswick
    W4 4NS London
    Amministratore
    50 Wavendon Avenue
    Chiswick
    W4 4NS London
    United KingdomBritish31140320001
    TATTAR, Balbinder Singh
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish105287960002
    YARDLEY, Gary James
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    Amministratore
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritish55671660002

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Trust deed
    Creato il 05 ott 2006
    Consegnato il 06 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £354,876,000 5.562 per cent. First mortgage debenture stock 2027 of capital & counties debenture PLC and all other moneys under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n sf 358502 l/h marland house 26-29 sloane street and 43-47 (odd numbers) pavillion road kensington london t/n LN216478 * for details of further property charged please refer to form 395 *. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 06 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of release and substitution
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 22 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/H property k/a queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n SF358502. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 22 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First supplemental trust deed
    Creato il 03 set 2002
    Consegnato il 04 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    The principal of £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies payable by virtue of any insurances on the mortgaged premises,as defined in the principal deed,pursuant to clauses 17(m) and 17(n) of the principal trust deed.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 04 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Deed of release and substitution
    Creato il 15 ott 2001
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/Hold property being dudley house,169 piccadilly,london W1; ngl 804655.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 04 mag 2000
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/Hold property being 32 and 33 long acre,london WC2; NGL775393.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 21 mag 1998
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/Hold property being 12 and 14 new fetter lane,london EC4; NGL573821.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 21 mag 1998
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/Hold property being carrington house,126,128 and 130 regent st,4 regent place and 36,38 and 40 warwick st,london W1; ngl 530323.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 02 giu 1997
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 11 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/H commonwealth house hammersmith london t/no NGL385177.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2003Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assurance and release
    Creato il 06 ott 1994
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    F/Hold property being capital place,bath rd,harlington; agl 443.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assurance and release
    Creato il 06 ott 1994
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/Hold property being walmar house,288-300 (even) regent st,15-16 great castle st,45-46 margaret st,london W1; t/no ngl 440302.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 14 mar 1991
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/Hold property being 190 strand,194 strand,2-8 maltravers st,canberra house,10-16 maltravers st,18-24 maltravers st,1 maltravers street and 7 arundel st,strand,london WC2; t/no NGL32297.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    Trust deed
    Creato il 14 mar 1991
    Acquisito il 03 set 2002
    Consegnato il 24 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    L/Hold property being marland house,26-29 sloane street and 43-47 (odd nos) pavillion rd,london SW1; t/no LN216478.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 24 set 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0