GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED

GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02220656
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Phoenix Building Central Boulevard
    Blythe Valley Park Shirley
    B90 8BG Solihull
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JBA SOFTWARE PRODUCTS LIMITED29 lug 199129 lug 1991
    OLYMPIC SOFTWARE LIMITED11 feb 198811 feb 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 mag 2012

    2 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    2 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mar 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di George Bisnought come amministratore in data 20 feb 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 gen 2012

    Stato del capitale al 11 gen 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2009

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio modificato redatto al 31 mag 2008

    9 pagineAAMD

    Bilancio redatto al 31 mag 2008

    2 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 31 mag 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OLDROYD, Andrew
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishFd136724940001
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    Segretario
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    BritishLawyer140313340001
    DANIELS, Pascale Isabelle Denise Louise Marie Ghuislaine
    2 Rue Van Winghen
    Anderlecht 1070
    Belgium
    Segretario
    2 Rue Van Winghen
    Anderlecht 1070
    Belgium
    British86539580001
    DEANE, Keith
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishExecutive113569550001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    Segretario
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    AmericanLawyer112513570001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    Segretario
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    AmericanExecutive112513570001
    JETHWA, Amritlal
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    Segretario
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    BritishFinance Director33776800004
    SUTTON, Matthew Jeremy
    15 Newfield Road
    DY9 0JP Hagley
    West Midlands
    Segretario
    15 Newfield Road
    DY9 0JP Hagley
    West Midlands
    BritishCompany Secretary92738100001
    TOWERS, Antony John
    The Hayloft Manor Farm Barns
    Stratford Road
    WR11 7PP Honeybourne
    Worcestershire
    Segretario
    The Hayloft Manor Farm Barns
    Stratford Road
    WR11 7PP Honeybourne
    Worcestershire
    BritishAccountant91463240002
    WILLIAMS, David
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    Segretario
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    British4180840002
    WRAGG, Peter Thomas Currie
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    BritishExecutive101526370002
    WRAGG, Peter Thomas Currie
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    BritishExecutive101526370002
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    Amministratore
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    United KingdomBritishLawyer140313340001
    BRIDDON, Kenneth Carl
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    BritishChief Executive Officer76868400001
    CULLENS, Alan Russell
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hampshire
    Amministratore
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hampshire
    BritishFinancial Director99247410001
    FLEISCHER, Russell Lawrence
    1504 Thomas Pl
    Forw Worth
    Texas 75252
    U.S.A.
    Amministratore
    1504 Thomas Pl
    Forw Worth
    Texas 75252
    U.S.A.
    United StatesAmericanExecutive154096470001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    Amministratore
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    United StatesAmericanExecutive112513570001
    JETHWA, Amritlal
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    Amministratore
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    BritishFinance Director33776800004
    JONES, John Kevin
    Southlands 1 Bearnett Drive
    WV4 5NN Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Southlands 1 Bearnett Drive
    WV4 5NN Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector68103800001
    JORDAN, Philip
    18 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TP London
    Amministratore
    18 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TP London
    BritishDirector51718170002
    KASPER, Jochen Berthold
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    Amministratore
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    GermanyGermanLawyer113569900002
    KLINGWALL, Per Nils Christer
    Forge Cottage
    10 Rosemary Lane
    HP17 8JS Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Forge Cottage
    10 Rosemary Lane
    HP17 8JS Haddenham
    Buckinghamshire
    SwedishFinancial Director70508330002
    NEEMAN, Ellen
    1 Tahoe Court
    Toronto
    M3b 3m6 Ontario
    Amministratore
    1 Tahoe Court
    Toronto
    M3b 3m6 Ontario
    CanadianLawyer70543520001
    NELSON, William George
    2217 Hidden Creek Court
    Lisle
    Illinois 60532
    Usa
    Amministratore
    2217 Hidden Creek Court
    Lisle
    Illinois 60532
    Usa
    AmericanCeo50467760007
    ROSE, Malcolm James
    46 Leigh Road
    WS4 2DS Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    46 Leigh Road
    WS4 2DS Walsall
    West Midlands
    BritishComputer Consultant21913860001
    SCIARD, Bertrand Andre Robert
    15 Avenue Sainte Foy
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    Amministratore
    15 Avenue Sainte Foy
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    FrenchDirector70543450001
    VICKERY, Alan Graham
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishChairman4180850001
    WHEELER, Paul Michael
    Squirrel Lodge
    Pinewoods Road Longworth
    OX13 5HH Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Squirrel Lodge
    Pinewoods Road Longworth
    OX13 5HH Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant76692640002
    WILLIAMS, David
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    Amministratore
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    EnglandBritishAccountant4180840002
    WRIGHT, Timothy John
    55b Hancock Street
    Lexington
    Massachusetts 02420
    Usa
    Amministratore
    55b Hancock Street
    Lexington
    Massachusetts 02420
    Usa
    BritishExecutive97675480001

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A loan,guaranty and security agreement
    Creato il 09 set 2003
    Consegnato il 18 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All loans,advances,debts, and principal due or to become due from the borrowers and duties of any kind due from the loan parties to the lender group under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The amount paid to the company on account of any rights of suborgation the company may eequire under any loan document to which it is party; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Foothill,Inc. Usa as a Lender and the Collateral Agent
    Transazioni
    • 18 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An intercompany subordination agreement
    Creato il 09 set 2003
    Consegnato il 18 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness due or to become due from the borrowers to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any payment of any kind to any of the subordinated creditors on account of the subordinated indebtedness; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Foothill,Inc. Usa as a Senior Creditor and the Security Agent
    Transazioni
    • 18 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2001
    Consegnato il 02 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies or liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent for the lenders (in such capacity the "agent") or any other loan party (as defined) (the "secured party") on any account whatsoever under pursuant to or in connection with the facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ableco Finance Llc
    Transazioni
    • 02 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 07 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant of the loan documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto Dominion Bank
    Transazioni
    • 07 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    Brevi particolari
    "Eagle house" the slough studley warwickshire and the goodwill and connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    Brevi particolari
    "Needles house" birmingham road studley warwickshire and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 21 mar 1994
    Consegnato il 25 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1993
    Consegnato il 05 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ott 2012Data di scioglimento
    26 mar 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robin Arthur Ellis
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.
    Praticante
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0