SHOPPING CENTRES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SHOPPING CENTRES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02230056 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SHOPPING CENTRES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova SHOPPING CENTRES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SHOPPING CENTRES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SIDEPLOY LIMITED | 14 mar 1988 | 14 mar 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SHOPPING CENTRES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per SHOPPING CENTRES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 17 mar 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Darren Windsor Richards come amministratore in data 11 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 206 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Sheridan Alexander Maudsley come amministratore in data 31 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Darren Windsor Richards il 21 mar 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018 | 14 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 186 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SHOPPING CENTRES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| LEWIS, Bryan | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House | United Kingdom | British | 58257940002 | |||||||||
| BAILEY, John Anthony | Segretario | Games Road EN4 9HX Barnet Ludgrove Hall 61-65 Hertfordshire | British | 134568600001 | ||||||||||
| DERRETT, Sarah | Segretario | 161a Conway Road Southgate N14 7BH London | British | 50906270001 | ||||||||||
| DINGLEY, Nigel Albert | Segretario | 22 Lyon Meadow Steeple Bumpstead CB9 7BY Haverhill Suffolk | British | 49198220001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 161590760001 | |||||||||||
| FIELD, Martin John | Segretario | 1 Hole Farm Cottages Albury Hall Park Albury SG11 2JE Ware Hertfordshire | British | 71986450002 | ||||||||||
| FIELD, Martin John | Segretario | 6 Jeffries Road SG12 7BB Ware Hertfordshire | British | 71986450001 | ||||||||||
| FIELD, Martin John | Segretario | 1 Hole Farm Cottages Albury Hall Park Albury SG11 2JE Ware Hertfordshire | British | 71986450002 | ||||||||||
| O'KEEFE, Helen Jane | Segretario | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 96031250001 | ||||||||||
| SANKAR, Nadine Amanda | Segretario | 90 Ebury Road WD17 2SB Watford | British | 72917320001 | ||||||||||
| AGER, Rowley Stuart | Amministratore | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 72555850002 | |||||||||
| BENJAMIN, Victor Woolf | Amministratore | The End House Sandy Lane Colemans Hatch TN7 4ER Hartfield East Sussex | British | 35534960001 | ||||||||||
| BURTON, Nigel | Amministratore | Farfield Farm Farfield Lane Cricklade SN6 6HZ Swindon Wiltshire | British | 38714610001 | ||||||||||
| CAREY, Roger William | Amministratore | Instow Burtons Way HP8 4BP Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 6069370001 | |||||||||
| CLARK, Alistair Ewan, Mr. | Amministratore | Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Tesco House Herts. United Kingdom | United Kingdom | British | 160520990001 | |||||||||
| EADE, Graham Peter | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | England | New Zealander | 160597430001 | |||||||||
| EARP, Neil Timothy | Amministratore | Tesco Plc Tesco House, Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Herts. | British | 83045240002 | ||||||||||
| EGGS, Anthony John | Amministratore | Beechwood House 15 Royse Grove SG8 9EP Royston Hertfordshire | British | 51584220001 | ||||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GIBNEY, John | Amministratore | Kitsbury Terrace HP4 3EE Berkhamstead 9 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 194216530001 | |||||||||
| HEAWOOD, John Anthony Nicholas | Amministratore | South View Road HA5 3YB Pinner Gateway Middlesex | United Kingdom | British | 133123780001 | |||||||||
| HOWELL, Robert | Amministratore | 30 Beech Drive N2 9NY London | British | 67469070001 | ||||||||||
| KINGSTON, Richard David | Amministratore | 4 Rookes Little Walden Road CB10 2EP Saffron Walden Essex | British | 10789160001 | ||||||||||
| LU, Hongyan Echo | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | Chinese | 171720380001 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| MERCER, Paul Vincent | Amministratore | Clearwater Chapel Road Rowledge GU10 4AN Farnham Surrey | British | 50858220001 | ||||||||||
| MOURANT, Nicholas Claud | Amministratore | Tesco House Delamare Road Cheshunt EN8 9SL Waltham Cross Hertfordshire | United Kingdom | British | 67463160002 | |||||||||
| OSBORN, Gareth John | Amministratore | 2 Orchard Coombe RG8 7QL Whitchurch Hill Oxfordshire | British | 91257750001 | ||||||||||
| PENFOLD, Julia | Amministratore | 33 Gurney Drive N2 0DF London | British | 67318640001 | ||||||||||
| POTTS, Anthony Bernard Joseph | Amministratore | 18 Oaklands Rise AL6 0RN Welwyn Hertfordshire | British | 13384100001 | ||||||||||
| REID, David Edward | Amministratore | Butler House Trinity Lane EN8 7EQ Waltham Cross Hertfordshire | British | 1485630002 | ||||||||||
| RICHARDS, Darren Windsor | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House | United Kingdom | British | 108462010003 | |||||||||
| RIGBY, Steven Andrew | Amministratore | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Waltham Cross | United Kingdom | British | 161159630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SHOPPING CENTRES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbl Properties Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SHOPPING CENTRES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 10 set 2014 Consegnato il 12 set 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 22 gen 2001 Consegnato il 25 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the finance documents (as defined) and/or any hedging agreement (as defined) except for any obligation which if it were so included would result in a contravention of section 151 of the company act 1985 | |
Brevi particolari Charged by way of a floating charge all its undertaking property (including real property) assets and rights present and future (including uncalled capital) wherever situated. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental charge | Creato il 09 gen 1996 Consegnato il 18 gen 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the loan agreement and/or the debenture both dated 20TH january 1989 | |
Brevi particolari The new property being f/h land and buildings situate on the eastern side of bennion road, leicester k/a the beaumont shopping centre, beaumont leys, leicester. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 20 gen 1989 Consegnato il 09 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15,000,000 "a" mortgage debenture stock 2001, £20,000,000 "b" mortgage debenture stock 2001 and £8,000,000 "c"mortgage debenture stock 2001 and all other monies intended to be secured by the trust deed. | |
Brevi particolari L/H surrey quays shopping redriff road, london SE16. F/h, clifton moor shopping centre, york. L/h, the beaumont centre, beaumont leys, leicester title no lt 153023 (for details see form 395 and continuation sheet relevant to this charge). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 20 gen 1989 Consegnato il 27 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and mortgage both dated 20/1/89 and this charge. | |
Brevi particolari By way of fixed charge, by way of legal mortgage ranking first in order of priority each and every part of the properties indicated on the continuation sheets attached to the form 395 ref: M224 together with all buildings, erections or structures at any time thereon and all landlords fixtures, fittings, fixtures, plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 gen 1989 Consegnato il 27 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and mortgage both dated 20/1/89 and this charge. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0