SHOPPING CENTRES LIMITED

SHOPPING CENTRES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHOPPING CENTRES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02230056
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHOPPING CENTRES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIDEPLOY LIMITED14 mar 198814 mar 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 17 mar 2022

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Darren Windsor Richards come amministratore in data 11 mar 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019

    15 pagineAA

    legacy

    206 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Charles Sheridan Alexander Maudsley come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Darren Windsor Richards il 21 mar 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018

    14 pagineAA

    legacy

    186 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United KingdomBritish58016770004
    LEWIS, Bryan
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United KingdomBritish58257940002
    BAILEY, John Anthony
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    Segretario
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    British134568600001
    DERRETT, Sarah
    161a Conway Road
    Southgate
    N14 7BH London
    Segretario
    161a Conway Road
    Southgate
    N14 7BH London
    British50906270001
    DINGLEY, Nigel Albert
    22 Lyon Meadow
    Steeple Bumpstead
    CB9 7BY Haverhill
    Suffolk
    Segretario
    22 Lyon Meadow
    Steeple Bumpstead
    CB9 7BY Haverhill
    Suffolk
    British49198220001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    161590760001
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    FIELD, Martin John
    6 Jeffries Road
    SG12 7BB Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Jeffries Road
    SG12 7BB Ware
    Hertfordshire
    British71986450001
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    O'KEEFE, Helen Jane
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Segretario
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British96031250001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    Segretario
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    British72917320001
    AGER, Rowley Stuart
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72555850002
    BENJAMIN, Victor Woolf
    The End House Sandy Lane
    Colemans Hatch
    TN7 4ER Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    The End House Sandy Lane
    Colemans Hatch
    TN7 4ER Hartfield
    East Sussex
    British35534960001
    BURTON, Nigel
    Farfield Farm
    Farfield Lane Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    Farfield Farm
    Farfield Lane Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    British38714610001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish6069370001
    CLARK, Alistair Ewan, Mr.
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Herts.
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Herts.
    United Kingdom
    United KingdomBritish160520990001
    EADE, Graham Peter
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandNew Zealander160597430001
    EARP, Neil Timothy
    Tesco Plc
    Tesco House, Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Herts.
    Amministratore
    Tesco Plc
    Tesco House, Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Herts.
    British83045240002
    EGGS, Anthony John
    Beechwood House 15 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Beechwood House 15 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    British51584220001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    EnglandBritish1898090001
    GIBNEY, John
    Kitsbury Terrace
    HP4 3EE Berkhamstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kitsbury Terrace
    HP4 3EE Berkhamstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish194216530001
    HEAWOOD, John Anthony Nicholas
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    Amministratore
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    United KingdomBritish133123780001
    HOWELL, Robert
    30 Beech Drive
    N2 9NY London
    Amministratore
    30 Beech Drive
    N2 9NY London
    British67469070001
    KINGSTON, Richard David
    4 Rookes
    Little Walden Road
    CB10 2EP Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    4 Rookes
    Little Walden Road
    CB10 2EP Saffron Walden
    Essex
    British10789160001
    LU, Hongyan Echo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomChinese171720380001
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58478890003
    MERCER, Paul Vincent
    Clearwater Chapel Road
    Rowledge
    GU10 4AN Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Clearwater Chapel Road
    Rowledge
    GU10 4AN Farnham
    Surrey
    British50858220001
    MOURANT, Nicholas Claud
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    United KingdomBritish67463160002
    OSBORN, Gareth John
    2 Orchard Coombe
    RG8 7QL Whitchurch Hill
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Orchard Coombe
    RG8 7QL Whitchurch Hill
    Oxfordshire
    British91257750001
    PENFOLD, Julia
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    Amministratore
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    British67318640001
    POTTS, Anthony Bernard Joseph
    18 Oaklands Rise
    AL6 0RN Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    18 Oaklands Rise
    AL6 0RN Welwyn
    Hertfordshire
    British13384100001
    REID, David Edward
    Butler House
    Trinity Lane
    EN8 7EQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    Butler House
    Trinity Lane
    EN8 7EQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    British1485630002
    RICHARDS, Darren Windsor
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United KingdomBritish108462010003
    RIGBY, Steven Andrew
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Waltham Cross
    Amministratore
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Waltham Cross
    United KingdomBritish161159630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tbl Properties Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione3863190
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SHOPPING CENTRES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 set 2014
    Consegnato il 12 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, London Branch (Facility Agent) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 12 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 22 gen 2001
    Consegnato il 25 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the finance documents (as defined) and/or any hedging agreement (as defined) except for any obligation which if it were so included would result in a contravention of section 151 of the company act 1985
    Brevi particolari
    Charged by way of a floating charge all its undertaking property (including real property) assets and rights present and future (including uncalled capital) wherever situated. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental charge
    Creato il 09 gen 1996
    Consegnato il 18 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the loan agreement and/or the debenture both dated 20TH january 1989
    Brevi particolari
    The new property being f/h land and buildings situate on the eastern side of bennion road, leicester k/a the beaumont shopping centre, beaumont leys, leicester. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Limited (As Agent and Trustee for and on Behalf of the Banks)
    Transazioni
    • 18 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 20 gen 1989
    Consegnato il 09 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000,000 "a" mortgage debenture stock 2001, £20,000,000 "b" mortgage debenture stock 2001 and £8,000,000 "c"mortgage debenture stock 2001 and all other monies intended to be secured by the trust deed.
    Brevi particolari
    L/H surrey quays shopping redriff road, london SE16. F/h, clifton moor shopping centre, york. L/h, the beaumont centre, beaumont leys, leicester title no lt 153023 (for details see form 395 and continuation sheet relevant to this charge).
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 09 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 nov 1997Registrazione di un'ipoteca
    • 26 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 gen 1989
    Consegnato il 27 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and mortgage both dated 20/1/89 and this charge.
    Brevi particolari
    By way of fixed charge, by way of legal mortgage ranking first in order of priority each and every part of the properties indicated on the continuation sheets attached to the form 395 ref: M224 together with all buildings, erections or structures at any time thereon and all landlords fixtures, fittings, fixtures, plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Limited
    Transazioni
    • 27 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1989
    Consegnato il 27 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and mortgage both dated 20/1/89 and this charge.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Limited
    Transazioni
    • 27 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0