CAREDANE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAREDANE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02230267
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAREDANE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CAREDANE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    238 Station Road
    Addlestone
    KT15 2PS Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAREDANE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CAREDANE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CAREDANE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2015

    Stato del capitale al 19 mag 2015

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2014

    Stato del capitale al 13 mag 2014

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mahesh Shivabhai Patel il 04 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Surendra Shivabhai Patel il 04 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per John Neal Alflatt il 04 feb 2010

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2008

    5 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2007

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 08 gen 2006

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CAREDANE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALFLATT, John Neal
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    British86320800002
    PATEL, Mahesh Shivabhai
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish80756410001
    PATEL, Surendra Shivabhai
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish44101520001
    HUSSAIN, Mussarat
    52 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    52 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    British9650510001
    GIRDHER, Andrew Rajesh, Doctor
    72b Mayford Road
    SW12 8SN London
    Amministratore
    72b Mayford Road
    SW12 8SN London
    British36908100002
    GIRDHER, Raj Kumar
    56 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    56 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    British9650520001
    HUSSAIN, Mussarat
    52 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    52 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish9650510001
    HUSSAIN, Syed Iqbal Tawassul
    52 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    52 Beeston Fields Drive
    Beeston
    NG9 3DD Nottingham
    Nottinghamshire
    British36908280001

    CAREDANE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 01 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 27 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land known a 108 110 112 and 114 broadgate beeston broxtowe chilwell nottinghamshire t/n NT185339,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 20 gen 2006
    Consegnato il 27 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property known as land and buildings lying on the south side of middle street beeston broxtowe nottinghamshire t/n NT16550 and f/h land and buildings on the south west side of hallam road chilwell broxtowe nottinghamshire t/n NT297456,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1998
    Consegnato il 03 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that freehold property known as land and buildings on the south side of middle street, beeston, nottingham title number NT16550 and all that property known as land and buildings on the south west side of hallam road, chilwell, nottingham title number NT297456.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 lug 1988
    Consegnato il 03 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    108,110,112 & 114 broadgate beeston nottinghamshire fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tsb England & Wales PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0