PREBON GROUP LIMITED

PREBON GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPREBON GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02230414
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PREBON GROUP LIMITED?

    • Attività di società holding di servizi finanziari (64205) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova PREBON GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    135 Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PREBON GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MARSHALLS FINANCE LIMITED13 dic 198813 dic 1988
    AUSHOLD LIMITED15 mar 198815 mar 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di PREBON GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PREBON GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 dic 2022

    LRESSP

    Memorandum e Statuto

    25 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 18 ott 2022

    • Capitale: GBP 0.25
    4 pagineSH02

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Tullett Prebon Investment Holdings Limited come persona con controllo significativo il 03 nov 2021

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Tullett Prebon Investment Holdings Limited come persona con controllo significativo il 07 mag 2021

    2 paginePSC05

    Nomina di Mr Andrew Ren-Yiing Chen come amministratore in data 01 apr 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robin James Stewart come amministratore in data 01 apr 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ England a 135 Bishopsgate London EC2M 3TP in data 07 mag 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Stato del capitale al 12 nov 2020

    • Capitale: GBP 17.85
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di PREBON GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHEN, Andrew Ren-Yiing
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish225251990001
    WILLIAMS, David Huw
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish134162960002
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Segretario
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BRILL, Tiffany Fern
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    218149260001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Segretario
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Segretario
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    DYER BARTLETT, Diana
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    177054120001
    HOSKINS, Justin Wilbert
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Segretario
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    171913630001
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Segretario
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Other132896170001
    RAVER, Harold Mark
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    Segretario
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    British1493340004
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleCOMPANIES ACT 2006
    Numero di registrazioneOC309455
    131429630001
    AIREY, Michael Gareth
    House B Greenland Villas
    8-12 Ma Yeung Path
    Kau To Shan
    Shatin
    Hong Kong
    Amministratore
    House B Greenland Villas
    8-12 Ma Yeung Path
    Kau To Shan
    Shatin
    Hong Kong
    British50290930003
    BADDELEY, Andrew Martin
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Amministratore
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    United KingdomBritish82469460001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    BOTTCHER, Friedrich Mathieu Jean
    Singel 192
    FOREIGN 1016 Aa Amsterdam
    Netherlands
    Amministratore
    Singel 192
    FOREIGN 1016 Aa Amsterdam
    Netherlands
    Dutch70253240003
    BURTON, Anthony David
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    UkBritish3513950001
    CAMERON SMAIL, Barry James
    4 Gorse Lane
    Wrecclesham
    GU10 4SD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    4 Gorse Lane
    Wrecclesham
    GU10 4SD Farnham
    Surrey
    British45139170001
    COLLIS, Sarah Ann
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    Amministratore
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    EnglandBritish35447290002
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    Amministratore
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    British54679190001
    DORJEE, Frank Franciscus
    Heidelaantje 3
    Huizen 1272 Pe
    Netherlands
    Amministratore
    Heidelaantje 3
    Huizen 1272 Pe
    Netherlands
    NetherlandsDutch162922400001
    EVANS, Andrew Keith
    177 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    177 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    EnglandBritish124021620001
    FRANKS, Louis Eric Arthur
    29 Baytree Walk
    WD1 3RX Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Baytree Walk
    WD1 3RX Watford
    Hertfordshire
    British68885740001
    GODDARD, Peter Anthony
    3 Aylmer Close
    HA7 3EQ Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    3 Aylmer Close
    HA7 3EQ Stanmore
    Middlesex
    British75308340003
    HARRISON, John Trevor
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish120531710001
    HIGAKI, Keiji
    3-43-4 Uehara
    Shibuya-Ku
    Tokyo
    151-0064
    Japan
    Amministratore
    3-43-4 Uehara
    Shibuya-Ku
    Tokyo
    151-0064
    Japan
    Japanese53144490002
    HIROSE, Kimtake
    A-1 3-13-1 Kamisaginomiya
    Nakano-Ku
    Tokyo
    Japan 165
    Amministratore
    A-1 3-13-1 Kamisaginomiya
    Nakano-Ku
    Tokyo
    Japan 165
    Japanese35279750001
    HOLMES, Deborah Ann
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Amministratore
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Australian113674080001
    HONKE, Masataka
    1-33-2 Higashiyurigoaka
    Asoh-Ku
    Kawasaki Kanagawa
    215-0012
    Japan
    Amministratore
    1-33-2 Higashiyurigoaka
    Asoh-Ku
    Kawasaki Kanagawa
    215-0012
    Japan
    Japanese75371270001
    HOOPER, David Charles
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    British85448170001
    HUGHES, Arthur Mcquade
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish1458920002
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Amministratore
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritish13013280001
    KEENAN, Patrick Michael
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Amministratore
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Australian42704380002
    KELSON, Christopher John Kerry
    441 E 84th Street
    New York
    Ny 10028
    United States
    Amministratore
    441 E 84th Street
    New York
    Ny 10028
    United States
    British2039010006
    KEMBER, William Percy
    83 Hillway
    Highgate
    N6 6AB London
    Amministratore
    83 Hillway
    Highgate
    N6 6AB London
    British6655760001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PREBON GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tp Icap Emea Investments Limited
    Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    135
    England
    06 apr 2016
    Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    135
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House (England And Wales)
    Numero di registrazione7042902
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PREBON GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second priority floating charge
    Creato il 26 feb 2001
    Consegnato il 16 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and at the times and in the manner provided in the guarantee and loan note (all as defined)
    Brevi particolari
    Subject to the prior ranking of the senior charge (as defined) all the company's property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever present and future including its uncalled share capital (if any) or such of them as the context requires.
    Persone aventi diritto
    • Yamane Tanshi Co LTD
    Transazioni
    • 16 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 28 giu 1999
    Consegnato il 01 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £164,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the interest of the company in the sum of £164,000.
    Persone aventi diritto
    • Railtrack PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 mag 1999
    Consegnato il 16 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee each and every liability arising under the finance documents which the company may have had at the time the debenture was entered into or thereafter have to the security trustee or any of the beneficiaries and pay to the security trustee every sum now or thereafter owing due or incurred by the company to the security trustee or any of the beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 16 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 23 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Tokyo International Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 23 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 28 feb 1989
    Consegnato il 13 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the lenders as defined in the loan agreement dated 27/2/89 under the terms of a guarantee of even date and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific National Bank
    Transazioni
    • 13 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 27 feb 1989
    Consegnato il 08 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the banks as defined in the loan agreement of even date under the terms of the said loan agreement and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific National Bankas Agent for Itself and the Banks as Defined Inthe Loan Agreement
    Transazioni
    • 08 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PREBON GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 dic 2022Inizio della liquidazione
    14 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0