EPS SECRETARIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EPS SECRETARIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02231995 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EPS SECRETARIES LIMITED?
- Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EPS SECRETARIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AF London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di EPS SECRETARIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per EPS SECRETARIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2022 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Peter Henry Williamson come amministratore in data 30 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Peter Scott come amministratore in data 31 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Iain Bernard Newman come amministratore in data 30 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Cms 1 South Quay Victoria Quays Sheffield South Yorkshire S2 5SY England a Cms 1 - 3 Charter Square Sheffield S1 4HS | 1 pagine | AD02 | ||
Nomina di Mr Stephen Samuel Alexander Millar come amministratore in data 30 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Peter Inkester come amministratore in data 30 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Nabarro Llp 1 South Quay Victoria Quays, Wharf Street Sheffield S2 5SY United Kingdom a Cms 1 South Quay Victoria Quays Sheffield South Yorkshire S2 5SY | 1 pagine | AD02 | ||
Notifica di Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp come persona con controllo significativo il 01 mag 2017 | 1 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp come persona con controllo significativo il 01 mag 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||
Chi sono gli amministratori di EPS SECRETARIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDRY, Benjamin Menzies | Segretario | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | 173864710001 | |||||||
| HENDRY, Benjamin Menzies | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | England | British | 142400450002 | |||||
| LUCK, Christopher Alan | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | England | British | 107460080001 | |||||
| MILLAR, Stephen Samuel Alexander | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | United Kingdom | British | 141680630002 | |||||
| NEWSHOLME, Caroline Norah | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | England | British | 124016770001 | |||||
| TAYLOR, Glyn Derek | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | United Kingdom | British | 67980990005 | |||||
| CROPLEY, Andrea Jayne | Segretario | 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon House United Kingdom | 147336990001 | |||||||
| HOLT, Richard Gordon | Segretario | Lindrick House Lindrick Lane DN11 9RA Tickhill,Doncaster South Yorkshire | British | 41084590001 | ||||||
| LIGHTBURN, Clive | Segretario | Wharf Lodge St Nicholas Way Bawtry DN10 6HB Doncaster South Yorkshire | British | 3302840004 | ||||||
| SIBLEY, Matthew James | Segretario | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | British | 97859570001 | ||||||
| BEVAN, Richard Henry Giles | Amministratore | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | United Kingdom | British | 123561550001 | |||||
| BURCHFIELD, Jonathan Robert | Amministratore | 15 The Court Bury Fields GU2 5BA Guildford Surrey | United Kingdom | British | 53095860001 | |||||
| CANTOR, Jonathan Brian | Amministratore | London Wall EC2Y 5AL London 125 England | United Kingdom | British | 123561400001 | |||||
| CROPLEY, Andrea Jayne | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon House United Kingdom | Uk | British | 142403570001 | |||||
| FURNESS-SMITH, Charles Edwin | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon House United Kingdom | United Kingdom | British | 102248830001 | |||||
| GRABINER, Martin Stanley | Amministratore | Rose Clematis Cottages Grewelthorpe HG4 3BT Ripon North Yorkshire | British | 69260060001 | ||||||
| HELLER, John Gibson | Amministratore | Poynatt`S Cottage Skirmett RG9 6TG Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 39394780003 | |||||
| HIERONS, Richard Charles | Amministratore | 69 Cranley Gardens Muswell Hill N10 3AB London | British | 17695340001 | ||||||
| HOLDEN, Russell David | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon House United Kingdom | United Kingdom | British | 123561650001 | |||||
| HOLT, Richard Gordon | Amministratore | Lindrick House Lindrick Lane DN11 9RA Tickhill,Doncaster South Yorkshire | British | 41084590001 | ||||||
| INKESTER, Andrew Peter | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | England | British | 142404050001 | |||||
| JACKSON, Robert Humphrey | Amministratore | 14 Dewhurst Road W14 0ET London | British | 47686950001 | ||||||
| JOHNSON, Michael | Amministratore | 50 Stratton Street W1X 5FL London | British | 22403920001 | ||||||
| LIGHTBURN, Clive | Amministratore | Wharf Lodge St Nicholas Way Bawtry DN10 6HB Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 3302840004 | |||||
| LOGAN, Gordon Niall | Amministratore | London Wall EC2Y 5AL London 125 England | United Kingdom | British | 54237930001 | |||||
| MACPHERSON, Ian | Amministratore | The Hollies Great North Road Barnby Moor DN22 8QX Retford Notts | United Kingdom | British | 32938220001 | |||||
| MARSHALL, Joanna Sarah | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8RW London Lacon House United Kingdom | United Kingdom | British | 142400080001 | |||||
| MARTIN-JONES, Rosemary | Amministratore | 76 Portobello Road W11 3DL London | British | 6144500001 | ||||||
| MENDELOW, Jonathan | Amministratore | 62 Blandfield Road SW12 8BG London | British | 53224860001 | ||||||
| NEWMAN, Iain Bernard | Amministratore | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | England | British | 66532510003 | |||||
| NOTT, Jennifer Jane | Amministratore | 17 Dauntless Road Burghfield Common RG7 3NZ Reading | British | 41739650001 | ||||||
| POINTON, Neil | Amministratore | Lynbar Martin Lane Bawtry DN10 6NJ Doncaster South Yorkshire | British | 60409920001 | ||||||
| PUGH, Keith William | Amministratore | The Cottage Harwell Lane Harwell Everton DN10 5BU Doncaster South Yorkshire | British | 40822970001 | ||||||
| RENGER, Michael | Amministratore | Vicarage Farm Wheston, Tideswell SK17 8JA Buxton Derbyshire | England | British | 142400550001 | |||||
| REYNARD, Charles William | Amministratore | Lindrick House Lindrick Common S81 8BA Worksop Nottinghamshire | British | 53593880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EPS SECRETARIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp | 01 mag 2017 | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp | 01 mag 2017 | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Nabarro Llp | 06 apr 2016 | London Wall EC2Y 5AL London 125 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0