REFRESCO (NELSON) LIMITED

REFRESCO (NELSON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREFRESCO (NELSON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02234044
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    • Produzione di bibite; produzione di acque minerali e altre acque imbottigliate (11070) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COTT (NELSON) LIMITED25 mag 200625 mag 2006
    MACAW (SOFT DRINKS) LIMITED26 feb 199026 feb 1990
    SANDING LIMITED22 mar 198822 mar 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    1 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Jan Abraham Pienaar come amministratore in data 16 feb 2021

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2017

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Cott Nelson (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 27 apr 2018

    2 paginePSC05

    Nomina di David Saint come amministratore in data 18 giu 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew James Vernon come amministratore in data 18 giu 2018

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name22 mag 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 21 mag 2018

    RES15

    Cessazione della carica di Claire Duffy come amministratore in data 30 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Kitching come amministratore in data 30 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jason Robert Ausher come amministratore in data 30 gen 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022340440019 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jason Robert Ausher il 12 dic 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SQUIRE PATTON BOGGS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    West Midlands
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2911328
    73037780028
    PIENAAR, Jan Abraham
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandDutch265177850001
    SAINT, David John
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritish84921030001
    CLAYTON, Arthur John Howard
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    Segretario
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    British7552130001
    FOSTER, George Jonathan
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    British51419380003
    MAIN, David Robert
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    Segretario
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    British76779080003
    SHORT, Mark Andrew
    Highcliffe Long Lane
    Southowram
    HX3 9UD Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    Highcliffe Long Lane
    Southowram
    HX3 9UD Halifax
    West Yorkshire
    British36567240002
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    67382580003
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    AUSHER, Jason Robert
    Corporate Center Iii At International Plaza
    Suite 400, 4221 W. Boy Scout Blvd.
    Tampa
    Cott Corporation
    Florida
    Usa
    Amministratore
    Corporate Center Iii At International Plaza
    Suite 400, 4221 W. Boy Scout Blvd.
    Tampa
    Cott Corporation
    Florida
    Usa
    United StatesAmerican188769770002
    BOARD, John Robert
    12 Chaigley Court
    Chaigley
    BB7 3ND Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    12 Chaigley Court
    Chaigley
    BB7 3ND Clitheroe
    Lancashire
    British93836050001
    BRENNAN, Catherine Marie Helen
    Sunnylea Avenue East Toronto
    Ontario
    M87 2k5
    63
    Canada
    Amministratore
    Sunnylea Avenue East Toronto
    Ontario
    M87 2k5
    63
    Canada
    Canadian133301470001
    CAWTHRAY, Andrew James
    Meadow Bank Farm Daleside Park
    HG3 2PX Darley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Meadow Bank Farm Daleside Park
    HG3 2PX Darley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish29428920003
    CLAYTON, Arthur John Howard
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish7552130001
    CORBY, Stephen
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritish176624850001
    DUFFY, Claire
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritish223323570001
    FOSTER, George Jonathan
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    British51419380003
    FOWDEN, Jeremy Stephen Gary
    The Paddocks 33 Twyford Road
    Barrow On Trent
    DE73 7HA Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    The Paddocks 33 Twyford Road
    Barrow On Trent
    DE73 7HA Derby
    Derbyshire
    British125265950001
    HOYLE, Jeremy Stephen
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritish153317170002
    JOYNSON, Andrew Douglas Stuart
    Farm
    Southam Road Napton On The Hill
    CV47 8NG Southam
    Red House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Farm
    Southam Road Napton On The Hill
    CV47 8NG Southam
    Red House
    Warwickshire
    United Kingdom
    British133301820001
    KITCHING, Steven
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritish223323760001
    KITCHING, Steven
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritish133273740001
    LEITER, Gregory
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    UsaUnited States140195590001
    LLOYD-DAVIES, Joanne
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritish176624840002
    MAIN, David Robert
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    Amministratore
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    British76779080003
    MARTIN, Paul John
    Ash Ghyll
    Bromley Road
    BD16 4DA Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ash Ghyll
    Bromley Road
    BD16 4DA Bingley
    West Yorkshire
    British70618780003
    MASON, Robert Andrew
    22 Howe Drive
    HP9 2BG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Howe Drive
    HP9 2BG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish40909900001
    MURFIN, Andrew James
    48 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    48 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish68921430001
    PRESLAR, B Clyde
    11913 Marblehead Drive
    FOREIGN Tampa
    Florida
    33626
    Amministratore
    11913 Marblehead Drive
    FOREIGN Tampa
    Florida
    33626
    American114826450001
    ROSE, Martyn Craig
    39a Limerston Street
    SW10 0BQ London
    Amministratore
    39a Limerston Street
    SW10 0BQ London
    British75808040001
    TURNER, Michael John
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritish121920530001
    VERNON, Matthew James
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Amministratore
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritish203388960001
    WALKER, Colin
    175 Meridene Crescent
    London
    Ontario N5x 1g3
    Canada
    Amministratore
    175 Meridene Crescent
    London
    Ontario N5x 1g3
    Canada
    Canadian115337890001
    WHITLEY, Nicholas Edward
    14 Milton Road
    DE65 6FZ Repton
    Derbyshire
    Amministratore
    14 Milton Road
    DE65 6FZ Repton
    Derbyshire
    United KingdomBritish170576580001
    WILLARD, Wynn A
    1097 Eden Isle Drive Ne
    FOREIGN St. Petersburg
    Florida 33704
    Usa
    Amministratore
    1097 Eden Isle Drive Ne
    FOREIGN St. Petersburg
    Florida 33704
    Usa
    Usa117606010001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REFRESCO (NELSON) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Refresco Nelson (Holdings) Limited
    Sideley
    Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Citrus Grove
    England
    06 apr 2016
    Sideley
    Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Citrus Grove
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Registry
    Numero di registrazione3464429
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    REFRESCO (NELSON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 ago 2016
    Consegnato il 12 ago 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Trademark "sunvill" with registration number 580919. trademark "sunquen" with registration number 735064. see instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A., London Branch
    Transazioni
    • 12 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 ago 2010
    Consegnato il 23 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A., London Branch (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 23 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the loan parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank N.A. as the Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2005
    Consegnato il 19 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the canadian borrower or any of its subsidiaries to the secured parties and all monies due or to become due from any borrower to any person that is a lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank, National Association Acting Through Its London Branch
    Transazioni
    • 19 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 08 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at lomeshaye industrial estae nelson lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 22 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings north west side of lindred road nelson lancashire t/no.LA654819. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 22 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 22 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a land & buildings on the south/ south east side of lindred road nelson lancashire. T/no. LA691938, LA78838, LA872068 & LA872069. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 lug 2000
    Consegnato il 01 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot of land situate at lomeshaye industrial estate nelson lancs t/no.LA586821. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 1998
    Consegnato il 16 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 11 giu 1998
    Consegnato il 16 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the policy NO23194-092-das.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1998
    Consegnato il 16 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a lindred road nelson lancashire-LA69193 & LA788384. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 ott 1996
    Consegnato il 28 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a premises at roseway lomeshaye industrial estate nelson lancashire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/orthe proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts andthe benefits of any licences legal mortgage and/or the proceeds of sale on l/h property k/a roseway lomeshaye industrial estate nelson t/n la 6577709.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises in roseway lomeshaye industrial estate nelson t/n la 657709 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second legal charge
    Creato il 03 set 1990
    Consegnato il 07 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease contract and master leasing agreement dated 3/9/90
    Brevi particolari
    The land and buildings together with all plant, fixtures (including tennant's and trade fixtures) and all machinery, fittings and equipment from time to time thereon being the land and buildings now known as 7 roseway situated at lindred road, lomeshaye industrial estate, nelson, lancashire.
    Persone aventi diritto
    • The Cca Partnership
    Transazioni
    • 07 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1990
    Consegnato il 12 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that of land having an area of three point eight six acres of thereabouts at lindred road nelson lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mag 1990
    Consegnato il 06 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 mag 1990
    Consegnato il 07 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Building agreement dated 9/4/90 relating to land at lindred road, nelson, lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0