GERANIUM PROPERTIES LIMITED

GERANIUM PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGERANIUM PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02235645
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GERANIUM PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova GERANIUM PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG LLP RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GERANIUM PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per GERANIUM PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 set 2010

    5 pagine4.68
    A81KUNI2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 ago 2010

    5 pagine4.68
    A81L9NII

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71
    A1KT1NDP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70
    AFUXNCAP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    AFUXVCAX

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 ago 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pagine287
    AFUXOCAQ

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    15 pagineAA
    A03WL9AD

    legacy

    4 pagine363a
    X46ZP8SV

    legacy

    1 pagine190
    X46ZO8SU

    legacy

    1 pagine353
    X46ZN8ST

    legacy

    3 pagine403a
    APSNW7VC

    legacy

    3 pagine403a
    APSNV7VB

    legacy

    3 pagine403a
    APSNU7VA

    legacy

    1 pagine225
    A4VZM745

    legacy

    1 pagine288b
    AYFUW42J

    legacy

    1 pagine288b
    A62JO3NF

    legacy

    1 pagine287
    AYH0E216

    legacy

    1 pagine288a
    ACFZ11AC

    legacy

    1 pagine225
    AXEG10CE

    legacy

    4 pagine363a
    XTLT3YSX

    Bilancio redatto al 30 apr 2007

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di GERANIUM PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNCAN, Stuart Andrew Weir
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    Segretario
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    BritishSolicitor80233100002
    WILLIAMS, Derwyn
    Sorensen Drive
    Figtree
    10
    New South Wales 2525
    Australia
    Segretario
    Sorensen Drive
    Figtree
    10
    New South Wales 2525
    Australia
    BritishCompany Secretary131796480001
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Amministratore
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Scotland UkBritishFinance Director42293490004
    LINDSAY, Kenneth Fraser
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector121520410001
    COWEN, Brendon Raymond
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    British1234020001
    HARKIN, Mark James
    66 Cantieslaw Drive
    East Kilbride
    G74 3AQ Glasgow
    Segretario
    66 Cantieslaw Drive
    East Kilbride
    G74 3AQ Glasgow
    BritishDirector42293490003
    MURPHY, Elizabeth Jane
    65 Teddington Park
    TW11 8DE Teddington
    Middlesex
    Segretario
    65 Teddington Park
    TW11 8DE Teddington
    Middlesex
    British32488100001
    OAKLEY, Robert James
    8 Marston Gardens
    LU2 7DU Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    8 Marston Gardens
    LU2 7DU Luton
    Bedfordshire
    British5232090001
    PRAIN, Graham Lindsay
    Waverley
    Granville Road, St Georges Hill
    KT13 0QJ Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Waverley
    Granville Road, St Georges Hill
    KT13 0QJ Weybridge
    Surrey
    British1234150002
    BUDDEN, Derek Ernest Arthur
    Elmfield 25 Batchworth Lane
    HA6 3DU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Elmfield 25 Batchworth Lane
    HA6 3DU Northwood
    Middlesex
    BritishChartered Accountant605520001
    GLOVER, Edward Douglas
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    Amministratore
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    United KingdomBritishMerchant Banker121380002
    LOCKHART, David Alfred Stevenson
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector35520610001
    MACKEY, Paul Emmanuel
    Woodview 23c Murray Court
    Sunninghill
    SL5 9BP Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Woodview 23c Murray Court
    Sunninghill
    SL5 9BP Ascot
    Berkshire
    IrishBanker11264820011
    MCALPINE, Adrian Neil Raeburn
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    United KingdomBritishProperty Executive27084300001
    TAYLOR, Simon Anthony
    The Gate House
    Sudbrook Lane
    TW10 7AT Richmond
    Surrey
    Amministratore
    The Gate House
    Sudbrook Lane
    TW10 7AT Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishDirector60774190002

    GERANIUM PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2003
    Consegnato il 05 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the l/h property k/a myrtle walk shopping centre being 1 to 30 myrtle walk and 143 to 151(a) (odd numbers) main street bingley t/n WYK392565. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that l/h land being 1 to 30 myrtle walk and 143 to 151A (odd NUMBERS0 main street bingley title absolute t/n WYK392565, all buildings and others tructures, the goodwill, all plant machinery and other items, the rental sums. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moscow Narodny Bank Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party deed of charge and set-off over cash
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 22 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower and from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights, title and interest in and to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moscow Narodny Bank Limited
    Transazioni
    • 22 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 set 2003
    Consegnato il 02 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h land being 14-22 (even) and 34 to 50 (even) brackley street and 1-11 market precinct farnworth bolton greater manchester t/n GM670322 together with any other assets or rights charged by the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moscow Narodny Bank Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 set 2003
    Consegnato il 30 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property market precinct, brackley street, farnworth, bolton t/n GM670322. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 set 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from halladale group PLC and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Moscow Narodny Bank Limited
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 01 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 04 apr 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 3RD april 1996 (as defined) and/or any of the other security documents
    Brevi particolari
    The regent centre on south west of cowgate,kirkintilloch registered on 23/2/90; t/no dmb 36298.
    Persone aventi diritto
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security
    Creato il 03 apr 1996
    Consegnato il 12 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility agreement dated 3RD april 1996 and this deed
    Brevi particolari
    All right,title and interest of the company in and to the supplementary agreement executed by the company on 3RD april 1996.
    Persone aventi diritto
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 12 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation
    Creato il 03 apr 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms and conditions as set out in the assignation deed
    Brevi particolari
    All rents and other sums payable now and in the future in terms of the leases 1. lease between the company and W.M. low supermarkets limited of major store unit the regent centre kirkintilloch t/n-DMB43060. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wurttembergische Hypothekenbank Akteingesellschaft
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge 0VER escrow deposit account
    Creato il 03 apr 1996
    Consegnato il 06 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all sums from time to time standing to the credit of the deposit account of the borrower at the royal bank of scotland PLC 62 threadneedle street account no 20393095. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wurtembergische Hypothekenbank Aktinegesellschaft
    Transazioni
    • 06 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 apr 1996
    Consegnato il 04 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 04 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 21 gen 1993
    Consegnato il 05 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground lying on the west side of the highs treet of arbroath and the county of angus ( see 395 for full details ).
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West Building Society
    Transazioni
    • 05 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 02 nov 1992
    Consegnato il 18 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a abbeygate shopping centre arbroath in the county of angus (see form 395 for full of the property shown).
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 18 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 06 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All and whole the lease dated 17 and 26 january registered in the books of council and session 23/4/90 and registered under t/n DMB36298 all and whole that plot or area of ground lying generally to the south west of cowgate kirkintilloch and now k/a the regent centre kirkintilloch described in the said lease.
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 06 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ott 1992
    Consegnato il 30 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or a receiver under the terms of the offer letter and/or the mortgage and/or the debenture deed (all as therein defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 30 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation and irrevocable mandate
    Creato il 26 ott 1992
    Consegnato il 03 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its whole right title and interest to receive the rent due under the leases of the property k/a the regent centre kirkintilloch.
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 03 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation and irrevocable mandate
    Creato il 26 ott 1992
    Consegnato il 03 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its whole right title and interest its rights to receive the rent due under the leases of the property k/a the abbeygate shopping centre arbroath angus.
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 03 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GERANIUM PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 ago 2009Inizio della liquidazione
    16 dic 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praticante
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0