DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02236715
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FORD HOUSE LIMITED21 giu 198821 giu 1988
    CHARTCLIMB LIMITED28 mar 198828 mar 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    6 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 320.44
    4 pagineSH19

    legacy

    6 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction in additional paid in capital 14/12/2014
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 nov 2014

    Stato del capitale al 17 nov 2014

    • Capitale: GBP 320.44
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 ott 2013

    Stato del capitale al 16 ott 2013

    • Capitale: GBP 320.44
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Dan Steven Agan come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Carlan Cooper come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Norman Tommy Barras come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Robert Theron Brockman come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Terry Wallace Jones come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Robert Maxey Nalley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Moss come amministratore

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 ott 2010

    • Capitale: GBP 320.44
    3 pagineSH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 ott 2010

    • Capitale: GBP 320.43
    3 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Segretario
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    AmericanDirector121496770001
    AGAN, Dan Steven
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanVice President84053880001
    BARRAS, Norman Tommy
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanVice President84053860001
    BROCKMAN, Robert Theron
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanPresident158497330001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmericanTreasurer121495910001
    COOPER, Carlan Max
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    UsaUnited StatesVice President136536270001
    JONES, Terry Wallace
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanVice President84053830001
    NALLEY, Robert Maxey
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmericanExecutive Vice President84053700001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    BritishCompany Secretary112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    BritishCompany Secretary112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Segretario
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Segretario
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    ARROWSMITH, Robert George
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    Amministratore
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    United KingdomBritishChartered Accountant70780350004
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    BritishAccountant112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Amministratore
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    United KingdomBritishChartered Accountant89866330001
    FABRE, Jeremie
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    Amministratore
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    FrenchLegal Director116364550001
    FORSYTH, Andrew James
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector64591610001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant94654870001
    MERRIMAN, Christopher Peter
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector63578740002
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Amministratore
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmericanAccountant121496770001
    ROBINSON, Timothy Michael
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director154155330001
    RUFF, David Hessel
    36 Oakford Drive
    Allesley
    CV5 7PP Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    36 Oakford Drive
    Allesley
    CV5 7PP Coventry
    West Midlands
    United KingdomBritishComputer Consultant23232440001
    SOANES, David
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    Amministratore
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    BritishManaging Director80021380001
    SPENCE, Raymond Leslie
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    BritishManaging Director46677090001
    STERKENBURG, Daniel Richard
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    Amministratore
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    AmericanFinancial Director116364510001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritishDirector42686850001

    DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 mar 2004
    Consegnato il 01 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 giu 2000
    Consegnato il 13 giu 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 nov 1997
    Consegnato il 18 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 mar 1993
    Consegnato il 16 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0