DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02236715 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
FORD HOUSE LIMITED | 21 giu 1988 | 21 giu 1988 |
CHARTCLIMB LIMITED | 28 mar 1988 | 28 mar 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 gen 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Dan Steven Agan come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Carlan Cooper come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Norman Tommy Barras come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Theron Brockman come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Terry Wallace Jones come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Maxey Nalley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Moss come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 ott 2010
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 ott 2010
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSS, Michael Craig | Segretario | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | American | Director | 121496770001 | |||||
AGAN, Dan Steven | Amministratore | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Vice President | 84053880001 | ||||
BARRAS, Norman Tommy | Amministratore | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Vice President | 84053860001 | ||||
BROCKMAN, Robert Theron | Amministratore | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | President | 158497330001 | ||||
BURNETT, Robert David | Amministratore | Post Oak Run 77355 Magnolia 28122 Texas Usa | United States | American | Treasurer | 121495910001 | ||||
COOPER, Carlan Max | Amministratore | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | Usa | United States | Vice President | 136536270001 | ||||
JONES, Terry Wallace | Amministratore | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Vice President | 84053830001 | ||||
NALLEY, Robert Maxey | Amministratore | 1200 Bristol Road South, Northfield, Birmingham B31 2RW West Midlands | United States | American | Executive Vice President | 84053700001 | ||||
BROMLEY, Christopher Philip | Segretario | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | Company Secretary | 112670520001 | |||||
BROMLEY, Christopher Philip | Segretario | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | Company Secretary | 112670520001 | |||||
CAMPBELL, Colin Stephen | Segretario | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | British | 89866330001 | ||||||
ROGERS, Wendy Fiona | Segretario | Fulbrook House 14 West End HP22 5TT Weston Turville Buckinghamshire | British | 72773920003 | ||||||
ARROWSMITH, Robert George | Amministratore | 8 Brendon Drive KT10 9EQ Esher | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 70780350004 | ||||
BROMLEY, Christopher Philip | Amministratore | 27 Morningside Earlsdon CV5 6PD Coventry West Midlands | British | Accountant | 112670520001 | |||||
CAMPBELL, Colin Stephen | Amministratore | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 89866330001 | ||||
FABRE, Jeremie | Amministratore | 4 Rue Du Lac Messery 74140 France | French | Legal Director | 116364550001 | |||||
FORSYTH, Andrew James | Amministratore | Well House Farm Pateley Bridge HG3 5NG Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 64591610001 | ||||
GUJRAL, Ben | Amministratore | Churchfield Lodge Churchfield Path EN8 9EG Cheshunt Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 94654870001 | |||||
MERRIMAN, Christopher Peter | Amministratore | 1 Oakdene Drive Barnt Green B45 8LQ Birmingham West Midlands | British | Director | 63578740002 | |||||
MOSS, Michael Craig | Amministratore | East Blooming Rose Court 77429 Cypress 17311 Texas Usa | United States | American | Accountant | 121496770001 | ||||
ROBINSON, Timothy Michael | Amministratore | Wells Farmhouse OX44 7PP Little Milton Oxfordshire | England | British | Managing Director | 154155330001 | ||||
RUFF, David Hessel | Amministratore | 36 Oakford Drive Allesley CV5 7PP Coventry West Midlands | United Kingdom | British | Computer Consultant | 23232440001 | ||||
SOANES, David | Amministratore | Fencewood House Slanting Hill RG18 9QQ Cold Ash Berkshire | British | Managing Director | 80021380001 | |||||
SPENCE, Raymond Leslie | Amministratore | 1 Mill Lane WS14 0DP Lichfield Staffordshire | British | Managing Director | 46677090001 | |||||
STERKENBURG, Daniel Richard | Amministratore | Rue De L'Eglise 7 Crans-Pres-Celigny 1299 Switzerland | American | Financial Director | 116364510001 | |||||
YAPP, Stephen | Amministratore | 4 The Tovells Off School Lane Ufford IP13 6HF Woodbridge Suffolk | England | British | Director | 42686850001 |
DCS OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creato il 12 mar 2004 Consegnato il 01 apr 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 05 giu 2000 Consegnato il 13 giu 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 07 nov 1997 Consegnato il 18 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 10 mar 1993 Consegnato il 16 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0