TAVERNER (2) LIMITED

TAVERNER (2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAVERNER (2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02241403
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAVERNER (2) LIMITED?

    • fabbricazione di articoli di plastica per edilizia (22230) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TAVERNER (2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TAVERNER (2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FIBRESEC MARKETING LIMITED20 ott 200520 ott 2005
    FIBRESEC LIMITED25 feb 199325 feb 1993
    FIBRELITE COMPOSITES LIMITED13 ott 198813 ott 1988
    BOLDSIGN LIMITED07 apr 198807 apr 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAVERNER (2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TAVERNER (2) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TAVERNER (2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed fibresec marketing LIMITED\certificate issued on 30/10/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name30 ott 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 ott 2013

    RES15

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 ott 2013

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Peter Thompson il 30 set 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Paul Heath il 30 set 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Ann Jacqueline Preston il 30 set 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    2 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    2 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TAVERNER (2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRESTON, Ann Jacqueline
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary110426760001
    HEATH, Martin Paul
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManufacturing Director20585800005
    THOMPSON, Ian Peter
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Unit 2 Snaygill Industrial Estat
    Keighley Road
    BD23 2QR Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director46127620002
    CROSSLAND, Reva
    Park House
    Bankwell Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    Segretario
    Park House
    Bankwell Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    British83891370001
    JENNINGS, Michael
    Unit 2
    Snaygill Industrial Estate
    Keighley Road
    Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Unit 2
    Snaygill Industrial Estate
    Keighley Road
    Skipton
    North Yorkshire
    British30584730001
    LEESING, Brian
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant19080600002
    THOMPSON, Ian Peter
    Merrimead
    Constable Road
    LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Merrimead
    Constable Road
    LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant46127620002
    CROSSLAND, John Stuart
    Park House Bankwell
    Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    Amministratore
    Park House Bankwell
    Giggleswick
    BD24 0AP Settle
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector83891300001
    JENNINGS, Michael
    Mickleden Ladder Banks Lane
    Baildon Shipley
    Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Mickleden Ladder Banks Lane
    Baildon Shipley
    Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector1951910001
    LEESING, Brian
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Limestones Back Lane
    Old Edlington
    DN12 1QA Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant19080600002
    PARDOE, Trevor William
    Woodstock House Bleach Mill Lane
    Menston
    LS29 6AN Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodstock House Bleach Mill Lane
    Menston
    LS29 6AN Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director3465590001

    TAVERNER (2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 set 1992
    Consegnato il 06 ott 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the loanstock deed as defined
    Brevi particolari
    See form 395 ref M532C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bayford & Company Limitedas Agent for the Stockholders
    Transazioni
    • 06 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 set 1992
    Consegnato il 05 ott 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 1988
    Consegnato il 26 ott 1988
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1, snaygill business centre, snaygill industrial estate, keighley road, skipton, north yorkshire part t/n nyk 37228.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 12 ott 1988
    Consegnato il 26 ott 1988
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1988Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0