DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED

DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02241896
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HANDYGIFT LIMITED01 mar 199401 mar 1994
    LONDON AND REGIONAL PROPERTIES LIMITED13 giu 198913 giu 1989
    GADE PROPERTIES LIMITED08 apr 198808 apr 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Chris Barton il 09 nov 2015

    1 pagineCH03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 ago 2015

    3 pagine4.68

    Nomina di Mr Chris Barton come segretario in data 05 gen 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Marcus Owen Shepherd come segretario in data 05 gen 2015

    1 pagineTM02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 ago 2014

    4 pagine4.68

    Nomina di Mr Marcus Owen Shepherd come segretario in data 01 set 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Helen Maria Ratsey come segretario in data 01 set 2014

    1 pagineTM02

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    11 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da * Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS* in data 03 set 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Matthew Weiner come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Barwick come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 apr 2013

    Stato del capitale al 30 apr 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Charles Julian Barwick il 11 ago 2012

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 08 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 29 feb 2012

    3 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Charles Julian Barwick il 29 set 2011

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193873580001
    MARX, Michael Henry
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish35019090001
    DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES PLC
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    United Kingdom
    Amministratore
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione657311
    53858600001
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Segretario
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    British33027500001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Segretario
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Segretario
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    British75831270001
    LIVINGSTONE, Richard John
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    Segretario
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    British51534890002
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158447900001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659990001
    BARWICK, Charles Julian
    Campana Road
    SW6 4AT London
    45
    England
    Amministratore
    Campana Road
    SW6 4AT London
    45
    England
    EnglandBritish3818640003
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Amministratore
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    British34902790002
    CHEER, Bruce Baxter
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    British66762930001
    CORDEREY, Neil Sinclair
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74024640001
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Amministratore
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    British75831270001
    LIVINGSTONE, Richard John
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    Amministratore
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    British51534890002
    ROSE, William Marcus Henderson
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    Amministratore
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    United KingdomBritish9127840001
    VAUGHAN, Steven Mark
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    British9092330001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    British4779170001
    WEINER, Matthew Simon
    24 Southway
    NW11 6RU London
    Amministratore
    24 Southway
    NW11 6RU London
    United KingdomBritish72888710002

    DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dted 23 december 1998)
    Creato il 18 feb 2002
    Consegnato il 07 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 104 camley street, l/b of camden including all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. Fixed charge all moneys from timr to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the principal deed. Floating charge the company's property assets rights and revenues, present and future including the unacalled share capital (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 07 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment
    Creato il 18 feb 2002
    Consegnato il 07 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from development securities PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests of the company to all moneys from time to time owing or incurred to the company under the leases in respect of 104 camley street, london (the lease) other than sums receivable by the company by way of insurance contributions service charge, payments to sinking funds or any vat payable thereon (rents) including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof (the assigned rights). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 07 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 lug 1995
    Consegnato il 17 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Whilem works, forest road, hainault, l/b of redbridge t/no.EGL7113.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 12 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rents licence fees & other like sums payable under the terms of any lease underlease agreement for lease or tenancy relating to the property k/a whilem works & lorely forest road hainault essex. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 12 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 12 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 12 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 ago 1993
    Consegnato il 06 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a gaywood house 29 great peter street vlondon t/no 221951 with fixtures & fittings fixed plant & machinery (other than trade).
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 ago 1993
    Consegnato il 06 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of yearly rents
    Creato il 20 ago 1993
    Consegnato il 06 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the agreement dated 19/8/93, the assignment or any related security document (as defined in the assignment)
    Brevi particolari
    All right title & interest in & to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the lease of building k/a gaywood house 29 great peter street london the benefit of any surety or guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Residual floating charge
    Creato il 29 gen 1993
    Consegnato il 13 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge the whole of the undertaking property and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1993
    Consegnato il 13 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 104 camley street london title no NGL474499. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment or rent
    Creato il 22 mag 1992
    Consegnato il 03 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge of even date
    Brevi particolari
    The benefit of all rents and all other sums payable under a lease together with any arrears existing at the date of this deed.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings k/a 52 standard rd, acton london t/no agl 12123 with a & goodwill & all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal & floating charge
    Creato il 11 mag 1992
    Consegnato il 16 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,350,000 & all other monies due from the company to the chargee on any account whatsoever & a participation fee in the maximum sum of £54,000 due from the company to the chargee (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    L/H land & building k/a 104 camley st, london t/no ngl 474499 with A. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 ago 1989
    Consegnato il 16 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 52 standard road acton london and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 lug 1989
    Consegnato il 13 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a units 1-18 telford close, burnett road norwich & the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1989
    Consegnato il 17 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a "loreley", forest road, hainault with fixed plant, machinery (except personal chattels) & the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited.
    Transazioni
    • 17 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 27 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a whilemworks, forest rd. Haincuilt tno elg 7113 tog with together with, fixed and plant machienry fixtures by way of:. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 27 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1989
    Consegnato il 07 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 94 ballords lane london N3. (Title no: mx 468172. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Banks Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 feb 1989
    Consegnato il 03 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    221 camben high street T.N. ln 92414. together with fixed plant machinery & other fixtures. & stocks of building materials goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 03 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 19 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    69 & 71 praed street, london W2 by way of a floating charge. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 19 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 08 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ago 2013Inizio della liquidazione
    17 giu 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas H O'Reilly
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Praticante
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0