TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02243256 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
- Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni
Dove si trova TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| KIER HOMES CALEDONIA LIMITED | 24 ott 2008 | 24 ott 2008 |
| KIER HOMES LIMITED | 01 mag 1998 | 01 mag 1998 |
| TWIGDEN HOMES MIDLANDS LIMITED | 03 giu 1988 | 03 giu 1988 |
| LOOKSTAKE LIMITED | 11 apr 1988 | 11 apr 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2025 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 24 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 07 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 24 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Daniel Stewart Wilson come segretario in data 30 set 2025 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU United Kingdom a Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park Solihull B90 8AU in data 14 lug 2025 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mamunur Rahman come amministratore in data 15 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian John Mitchell come amministratore in data 31 gen 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2024 | 16 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 71 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2023 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Trevor David Thomas come amministratore in data 31 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gareth Russell Jacob come amministratore in data 13 giu 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2022 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr James Jonathan Hiles come amministratore in data 30 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2023 al 31 mar 2023 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2021 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Daniel Stewart Wilson come segretario in data 31 mag 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Tilia Homes Limited come persona con controllo significativo il 16 ago 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da One St Peter's Square Manchester United Kingdom M2 3DE United Kingdom a Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU in data 16 ago 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Bosley Phillips come amministratore in data 15 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Tilia Homes Limited come persona con controllo significativo il 09 giu 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILES, James Jonathan | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 265522960001 | |||||
| JACOB, Gareth Russell | Amministratore | Central Boulevard Shirley B90 8AU Solihull Tungsten Building England | England | British | 303523150001 | |||||
| RAHMAN, Mamunur | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 323769010001 | |||||
| ARMITAGE, Matthew | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 193475380001 | |||||||
| BRAND, Duncan Valentine | Segretario | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | British | 16800690001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Segretario | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GREGORY, Robert William | Segretario | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | British | 109817750001 | ||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | British | 116752570006 | ||||||
| HIGGINS, Philip | Segretario | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | 262491930001 | |||||||
| KANE, Paul Edward | Segretario | 48 Katewell Avenue Drumchapel G15 8ER Glasgow Lanarkshire Scotland | British | 88265100001 | ||||||
| MCCOLL, Mary Jean | Segretario | Keysoe Lodge Keysoe Row West MK44 2JF Keysoe Bedfordshire | British | 34757030001 | ||||||
| MCDONAGH, Stuart Ali | Segretario | 19 Greek Thomson Road Balfron G63 0RE Glasgow Lanarkshire | British | 117628720001 | ||||||
| MELGES, Bethan | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 199691300001 | |||||||
| TWIGDEN, David Robert | Segretario | 21 Duloe Road St Neots PE19 4HW Huntingdon Cambridgeshire | British | 37904870001 | ||||||
| WILSON, Daniel Stewart | Segretario | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | 299160360001 | |||||||
| AITCHISON, Andrew William | Amministratore | 9 Finlayson Place FK5 4FX Larbert Stirlingshire | United Kingdom | British | 104820240002 | |||||
| ANDERSON, John Bruce | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 29878320002 | |||||
| BRAND, Duncan Valentine | Amministratore | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 16800690001 | |||||
| BROOMFIELD, Matthew | Amministratore | 11 Centenary Road Brampton PE28 4YQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 108705890001 | ||||||
| BROWNE, Daniel Harry Rate | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 154494390001 | |||||
| COOPER, Sarah Jayne | Amministratore | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | United Kingdom | British | 188395230001 | |||||
| COPE, David | Amministratore | 7 Castle Gardens Ballikinrain G63 0LT Glasgow Strathclyde | British | 68139500002 | ||||||
| CREMIN, Theresa Bernadette | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 185269400001 | |||||
| DUFFY, Allan | Amministratore | 11 Tollhouse Way Girdle Toll KA11 1RB Irvine Ayrshire | British | 68139530001 | ||||||
| FERGUSON, Isabella | Amministratore | 22 Chelmsford Drive G12 0NA Glasgow | United Kingdom | British | 116248510002 | |||||
| GALLOWAY, Bryan Thomas | Amministratore | 31 Bellefield Crescent ML11 7QY Lanark Lanarkshire | British | 122141580001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Amministratore | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GORDON-STEWART, Alastair James | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 124512200002 | |||||
| GREGORY, Robert William | Amministratore | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| GREGORY, Robert William | Amministratore | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| HOLDOM, Denise Ivy | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Lysander House Bedfordshire | England | British | 116935560002 | |||||
| HOMER, David | Amministratore | 28 Eastwood Drive Highwoods CO4 4EB Colchester Essex | British | 16658920001 | ||||||
| HOPE, Lorna Jane | Amministratore | 35 Cameron Street KY12 8DP Dunfermline Fife | British | 82965270001 | ||||||
| KANE, Paul Edward | Amministratore | 48 Katewell Avenue Drumchapel G15 8ER Glasgow Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 88265100001 | |||||
| KING, Christopher | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 81798580013 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TILIA HOMES CALEDONIA LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia Homes Limited | 06 apr 2016 | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0