MINORIES GARAGES LIMITED
Panoramica
Nome della società | MINORIES GARAGES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02245228 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MINORIES GARAGES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MINORIES GARAGES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 770 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MINORIES GARAGES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ALLERIM LIMITED | 18 apr 1988 | 18 apr 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MINORIES GARAGES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MINORIES GARAGES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 lug 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Bishop come amministratore in data 01 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David John Muir come amministratore in data 01 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 49 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MINORIES GARAGES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINCH, Mark | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175736280001 | |||||||
FINCH, Mark Charles | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 175612870001 | ||||
MUIR, David John | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | Company Director | 254017640001 | ||||
MACNAMARA, Richard James | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149316250001 | |||||||
WARD, Andrew Ian | Segretario | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
WATSON, Deirdre Mary Alison | Segretario | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
MATHESON & CO LIMITED | Segretario | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
ANDERSON, James Michael | Amministratore | 43 Kingswell NE61 2TY Morpeth Northumberland | England | British | Accountant | 11487420001 | ||||
ATKIN, John Richard | Amministratore | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | Financial Director | 20102900001 | |||||
BANHAM, Gillian | Amministratore | 2 Dye House Meadow Liston Lane CO10 9LD Long Melford Suffolk | British | Group Hr Director | 56735910001 | |||||
BEATTIE, Craig Alan | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 177627900001 | ||||
BEYNON, Peter | Amministratore | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | Group Finance Director | 38504390006 | ||||
BISHOP, Matthew | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 206755450002 | ||||
CHAMBERS, Paul Jonathan | Amministratore | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | Finance Director | 1188140001 | |||||
COXON, Jeffrey Lance | Amministratore | Whitehill Hall Gardens DH2 2NE Chester Le Street 2 Co Durham United Kingdom | United Kingdom | British | Manager | 135123710001 | ||||
ELIAS, Symon | Amministratore | 11 Deyncourt Ponteland NE20 9RP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Manager | 28841470001 | |||||
HERBERT, Mark Philip | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | Company Director | 123285980005 | ||||
HOUSTON, Samuel George | Amministratore | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | Finance Director | 75730290003 | |||||
JONES, Alun Morton | Amministratore | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 12785600004 | ||||
MACLAREN, Niall Craig | Amministratore | Oak House Hollies Lane SK9 2BW Wilmslow Cheshire | England | British | Manager | 32232190002 | ||||
MACNAMARA, Richard James | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 149294820002 | ||||
POTTS, Derek | Amministratore | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | Finance Director | 52485510001 | ||||
RITCHIE, John Muir | Amministratore | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | Director | 22325820001 | |||||
TAYLOR, Phillip | Amministratore | 63 Cornmoor Road Whickham NE16 4PU Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | Company Director | 83887910001 | |||||
WATSON, Deirdre Mary Alison | Amministratore | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | Company Secretary | 74385360001 | ||||
WILLIAMS, Steven Wyn | Amministratore | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 54580940001 | ||||
WILLIAMSON, Michael Granville | Amministratore | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | Chairman & Chief Executive | 57360160001 | |||||
WITT, John Raymond | Amministratore | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | Finance Director | 51303670001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MINORIES GARAGES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appleyard Group Limited | 06 apr 2016 | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MINORIES GARAGES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 18 apr 1994 Consegnato il 05 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture | |
Brevi particolari All those monies which may be owing to the company by vag (united kingdom) limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Used vehicle charge | Creato il 14 dic 1992 Consegnato il 15 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All its interests in any used cars and unused vehicles under the terms of the used vehicle sale agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 apr 1991 Consegnato il 23 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All monies which from time to time be owing to the company. See form 395 (ref 55) for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 11 ago 1988 Consegnato il 15 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 11.8.88 | |
Brevi particolari All the chargor's interst (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 21 lug 1988 Consegnato il 10 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Floating charge over the undertaking & all other property assets & rights including stock in trade. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Part of dragonville garage alma place, gilesgate moor durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari F/H land at church road stockton on tees, together with buildings thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Land on south side of alma place durham title no du 107256. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari F/H land and buildings at beneton road ethershore avenue newcastle upon tyne. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Land on N.e side of dixons bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Part of dragonville garage alma place, gilesgate moor durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Land on east side of newcastle road, sunderland title no ty 100340. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari F/H land on S.w side of dixons bnak marton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Brevi particolari Land in newcastle road, sunderland tyne and wear. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari F/H land at station road ashington northumberland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari F/H land k/a grandstord garage kenton road gosforth t/no ty 27338. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari Land together with the garage erected thereon and k/a north hylton garage. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 15 lug 1988 Acquisito il 22 lug 1988 Consegnato il 12 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari L/H factory & land being site number BT1/R386 team valley trading estate gateshead t/no ty 200404. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0